LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01936379 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED ?
Adresse du siège social | Newbury House Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Wiltshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 30 juil. 2019
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Graham Murray Lynch Staunton le 22 oct. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2018 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lynne Margaret Lovell en tant que directeur le 16 févr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Susan Angela Lynch-Staunton le 20 sept. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Susan Angela Clayton-Smith le 27 juil. 2017 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Lynne Margaret Lovell en tant qu'administrateur le 27 janv. 2017 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 août 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 août 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Alan Thompson en tant que directeur le 01 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed constance carroll LIMITED\certificate issued on 26/11/14 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNCH STAUNTON, Graham Murray | Administrateur | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 77490420006 | ||||
LYNCH-STAUNTON, Susan Angela | Administrateur | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire United Kingdom | England | British | Uk Sales Director | 165079930008 | ||||
MUSHET, Norman Buchanan | Secrétaire | 5 Howgill Close Ledsham Park CH66 4JH Little Sutton Cheshire | British | 105077220001 | ||||||
RING, Leo Joseph | Secrétaire | 3 Fairways IRISH Rathfarnham Dublin 14 Ireland | Irish | Co Secretary | 97021090001 | |||||
RING, Leo Joseph | Secrétaire | 3 Fairways IRISH Rathfarnham Dublin 14 Ireland | Irish | Co Secretary | 97021090001 | |||||
ROBERTS, Timothy Edward | Secrétaire | 19 Grammar School Road WA13 0BQ Lymm Cheshire | British | 14876480002 | ||||||
CARPENTER, Brian William | Administrateur | Willan House Highland Road, Badgers Mount TN14 7BA Sevenoaks Kent | England | British | Sales Director | 14876490002 | ||||
HICKIE, Gerard | Administrateur | Higher House Farm Castle Mill Lane WA15 0RA Ashley Cheshire | Irish | Managing Director | 85735370004 | |||||
HUGHES, Loraine | Administrateur | Walsham Gardens WA9 5UT St. Helens 38 Merseyside | England | British | Finance Director | 138239430001 | ||||
LOVELL, Lynne Margaret | Administrateur | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire Uk | England | British | Finance And Operations Director | 251923560001 | ||||
MARSH, Stephen Beverley | Administrateur | Home Farm Liverpool Road Ashton In Makerfield WN4 9LX Wigan Lancashire | British | Company Director | 36100180002 | |||||
MURPHY, James Michael | Administrateur | 36 Ulverton Road IRISH Dalkey Co Dublin Ireland | Ireland | Irish | Director | 51806010005 | ||||
MUSHET, Norman Buchanan | Administrateur | 5 Howgill Close Ledsham Park CH66 4JH Little Sutton Cheshire | British | Accountant | 105077220001 | |||||
O'BRIEN, Paul | Administrateur | 3 Fox Lodge Road Fox Lodge Woods IRISH Ratoath Ireland | Ireland | Irish | Director | 96999430001 | ||||
OTLEY, Richard Reverdy | Administrateur | 4 Osborne Way HP23 6EN Wiggington Hertfordshire | United Kingdom | British | Investment Analyst | 127085630001 | ||||
ROBERTS, Timothy Edward | Administrateur | 19 Grammar School Road WA13 0BQ Lymm Cheshire | British | Finance Director | 14876480002 | |||||
SOROKIN, Alexander | Administrateur | 10 Sterling Street SW7 1HN London | American | Corporate Financier | 111747170001 | |||||
THOMPSON, John Alan | Administrateur | Grimrod Place East Gillibrands WN8 9UU Skelmersdale 22 Lancashire United Kingdom | England | British | Supply Chain Director | 60966890001 | ||||
WILKINSON, Alan Geoffrey | Administrateur | 1 Sunningdale Gardens Freshfield Road L37 3RL Formby Liverpool Merseyside | British | Company Director | 14876510002 | |||||
WILKINSON, Geoffrey Harold | Administrateur | Dalton House Higher Lane Dalton WN8 7RP Wigan Lancashire | British | Company Director | 14876520001 | |||||
WILKINSON, Peter Alan | Administrateur | Uplands Higher Lane, Dalton WN8 7TW Wigan Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 87473650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynch-Staunton Cosmetics Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Aintree Avenue White Horse Business Park BA14 0XB Trowbridge Newbury House Wiltshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
LYNCH-STAUNTON COSMETICS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 19 juil. 2012 Livré le 24 juil. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security agreement | Créé le 28 mars 2006 Livré le 11 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over property and assets including goodwill bookdebts uncalled plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Security agreement | Créé le 09 juin 2004 Livré le 28 juin 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each chargor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 27 mai 1988 Livré le 06 juin 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed and machinery all stocks, shares & other securities. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0