CASTLE HOME VIDEO LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CASTLE HOME VIDEO LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01938596 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CASTLE HOME VIDEO LIMITED ?
| Adresse du siège social | 33 Wigmore Street W1U 1QX London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CASTLE HOME VIDEO LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CASTLE HOME VIDEO LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour CASTLE HOME VIDEO LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Maximilian Dressendoerfer le 17 oct. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark David Ranyard le 17 oct. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2013 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 27 août 2014
| 4 pages | SH01 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Davenport Lyons 6 Agar Street London WC2N 4HN England à Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London W1D 3JB | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London W1D 3JB | 1 pages | AD03 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Beaumont House Avonmore Road Kensington Village London W14 8TS United Kingdom | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Davenport Lyons 30 Old Burlington Street London W1S 3NL England le 10 sept. 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Mark David Ranyard en tant qu'administrateur le 30 avr. 2013 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Maximilian Dressendoerfer en tant qu'administrateur le 30 avr. 2013 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de John Leslie Dobinson en tant qu'administrateur le 30 avr. 2013 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Spencer Smith en tant que directeur le 30 avr. 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 364-366 Kensington High Street London W14 8NS England le 06 juin 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Nomination de Timothy Spencer Smith en tant qu'administrateur le 21 nov. 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Abolanle Abioye en tant que secrétaire le 21 nov. 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Adam Martin Barker en tant que directeur le 21 nov. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de David Richard James Sharpe en tant que directeur le 21 nov. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CASTLE HOME VIDEO LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBINSON, John Leslie | Administrateur | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | United Kingdom | British | 34942720003 | |||||
| DRESSENDOERFER, Maximilian, Dr | Administrateur | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | Germany | German | 157717080010 | |||||
| RANYARD, Mark David | Administrateur | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | England | British | 154884950002 | |||||
| ABIOYE, Abolanle | Secrétaire | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | British | 88802330001 | ||||||
| COOK, Edward John Nicholas | Secrétaire | Flat 2 47 Crooked Billet SW19 4RQ London | British | 59798700002 | ||||||
| HOLDER, Ian Keith | Secrétaire | 39a Great Percy Street WC1X 9RD London | British | 60759970001 | ||||||
| JOY, Matthew Robert | Secrétaire | 2 Chestnut Place KT21 2DY Ashtead Surrey | British | 115905420001 | ||||||
| O'BRIEN, Judith Elizabeth | Secrétaire | Glinton Cottage Milton Avenue Chalfont St Peter SL9 8QW Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 53890870001 | ||||||
| STANDING, Sarah Elizabeth Anne | Secrétaire | 1 Pilsdon Close Inner Park Road Wimbledon SW19 6DR London | British | 41378870002 | ||||||
| CITY GROUP PLC | Secrétaire | 25 City Road EC1Y 1BQ London | 35794270001 | |||||||
| BARKER, Adam Martin | Administrateur | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | British | 162279360001 | |||||
| BEECHER, Jonathan Roderick | Administrateur | Great Oaks 7 Woodway Merrow GU1 2TF Guildford Surrey | British | 4641390002 | ||||||
| BRYANT, David Thomas | Administrateur | Ramillies Road W4 1JW London 37 United Kingdom | England | British | 129141390001 | |||||
| COKELL, Joseph | Administrateur | Talltrees Orpington Road BR7 6RA Chislehurst Kent | Gb-Eng | British | 76396440001 | |||||
| CONSTANT, Richard Michael | Administrateur | 6 Balniel Gate SW1V 3SD London | United Kingdom | British | 43836310003 | |||||
| COOK, Edward John Nicholas | Administrateur | 25 Ernle Road Wimbledon SW20 0HH London | British | 59798700004 | ||||||
| FISHER, Thomas Clive | Administrateur | 1 Nevelle Close Binfield RG42 4AZ Bracknell Berkshire | England | British | 26978160002 | |||||
| MUIR, Boyd Johnston | Administrateur | The Street Albury GU5 9AX Guildford Old Rectory Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 129432950001 | |||||
| SEMON, Roger | Administrateur | Kingsfield Kings Lane Cobblers Hill HP16 9PN Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 59798610002 | |||||
| SHAND, Terence Richard | Administrateur | Winkins Wood Farm Shillinglee Road Plaistow RH14 0PQ Billingshurst West Sussex | British | 4641400002 | ||||||
| SHARPE, David Richard James | Administrateur | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | Irish | 166109150001 | |||||
| SMITH, Timothy Spencer | Administrateur | Avonmore Road Kensington Village W14 8TS London Beaumont House United Kingdom | England | British | 130003340001 | |||||
| WALLACE, Paul Frederick | Administrateur | Westfield House Nunnery Lane TN11 8HA Penshurst Kent | England | British | 76655520001 |
CASTLE HOME VIDEO LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Créé le 07 mai 1991 Livré le 09 mai 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 22 déc. 1988 Livré le 11 janv. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 19 oct. 1987 Livré le 28 oct. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 26 juin 1987 Livré le 03 juil. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge on all book & other debts owing to the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (exceeding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 26 juin 1987 Livré le 03 juil. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H property k/a flat 7 rippon house, hornchurch essex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0