BEACON GAMING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBEACON GAMING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01942151
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BEACON GAMING LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BEACON GAMING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Seebeck House 1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BEACON GAMING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BEACON ENTERTAINMENTS LIMITED14 janv. 199814 janv. 1998
    BEACON ENTERTAINMENTS HOLDINGS LIMITED27 août 198527 août 1985

    Quels sont les derniers comptes de BEACON GAMING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BEACON GAMING LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BEACON GAMING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    GAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 04 mars 2014

    • Capital: GBP 0.50
    4 pagesSH19

    État du capital

    SH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 déc. 2012

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Kevin Hamilton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Andrew James Hall en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 25 déc. 2011

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 17a/17B Market Place Loughborough Leicestershire LE113EA* le 06 mars 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin Hamilton le 01 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Nomination de Byron Evans en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Matthew Proctor en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Matthew Proctor en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 26 déc. 2010

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Brian Mattingley en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Qui sont les dirigeants de BEACON GAMING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EMW SECRETARIES LIMITED
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    Secrétaire
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3512570
    93910510003
    EVANS, Byron
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishCommercial Director140884750001
    HALL, Andrew James
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director30306840002
    HARDING, Nicholas Simon
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive Officer150860820001
    CRANAGE, Sidney Derek
    Cranick Lodge 259a Nanpantan Road
    Nanpantan
    LE11 3YD Loughborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    Cranick Lodge 259a Nanpantan Road
    Nanpantan
    LE11 3YD Loughborough
    Leicestershire
    British39964180001
    MATTINGLEY, Brian
    17a/17b Market Place
    Loughborough
    Leicestershire
    Le113ea
    Secrétaire
    17a/17b Market Place
    Loughborough
    Leicestershire
    Le113ea
    150195950001
    MURRAY, Stephanie
    17a/17b Market Place
    Loughborough
    Leicestershire
    Le113ea
    Secrétaire
    17a/17b Market Place
    Loughborough
    Leicestershire
    Le113ea
    Australian123290920002
    PROCTOR, Matthew Frederick
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    Secrétaire
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    151171960001
    VINER, Paul
    20 Denman Drive North
    NW11 6RB London
    Secrétaire
    20 Denman Drive North
    NW11 6RB London
    BritishDirector117768960001
    WHITE, Shirley Janice
    16 Charnwood Fields
    Sutton Bonington
    LE12 5NP Loughborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    16 Charnwood Fields
    Sutton Bonington
    LE12 5NP Loughborough
    Leicestershire
    British24512540001
    CLARKE, John Thomas
    56 Salcombe Drive
    Glenfield
    LE3 8AF Leicester
    Administrateur
    56 Salcombe Drive
    Glenfield
    LE3 8AF Leicester
    BritishAccountant38599630001
    CRANAGE, Sidney Derek
    Cranick Lodge 259a Nanpantan Road
    Nanpantan
    LE11 3YD Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    Cranick Lodge 259a Nanpantan Road
    Nanpantan
    LE11 3YD Loughborough
    Leicestershire
    BritishDirector39964180001
    CRISP, John William Francis
    Robins Nest
    Six Hills Road Walton On The Wolds
    Loughborough
    Leics
    Administrateur
    Robins Nest
    Six Hills Road Walton On The Wolds
    Loughborough
    Leics
    BritishCompany Director7205890001
    DIXON, Gillian
    Croft House
    High Hesket
    CA4 0HS Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    Croft House
    High Hesket
    CA4 0HS Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritishCommercial Director146371490001
    DUFFY, Patrick Michael Sario
    109 Sycamore Road
    East Leake
    LE12 6PR Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    109 Sycamore Road
    East Leake
    LE12 6PR Loughborough
    Leicestershire
    IrishCompany Director25179310001
    HAMILTON, Kevin
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1a Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishLeisure147485660001
    HANNAH, Simon
    35 Turgis Road
    GU51 1EL Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    35 Turgis Road
    GU51 1EL Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector98633850001
    JEPP, Mark
    67 Humber Street
    DE65 5NW Hilton
    Derbyshire
    Administrateur
    67 Humber Street
    DE65 5NW Hilton
    Derbyshire
    EnglandBritishManager184171270001
    MATTINGLEY, Brian Roger
    17a/17b Market Place
    Loughborough
    Leicestershire
    Le113ea
    Administrateur
    17a/17b Market Place
    Loughborough
    Leicestershire
    Le113ea
    United KingdomBritishChairman22417130002
    MURRAY, Stephanie
    17a/17b Market Place
    Loughborough
    Leicestershire
    Le113ea
    Administrateur
    17a/17b Market Place
    Loughborough
    Leicestershire
    Le113ea
    EnglandAustralianFinance Director123290920002
    PROCTOR, Matthew Frederick
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishNone136671560001
    THOMAS, Alma June
    Parks Farm House
    Nanpantan Road
    LE11 3YE Loughborough
    Leics
    Administrateur
    Parks Farm House
    Nanpantan Road
    LE11 3YE Loughborough
    Leics
    BritishCompany Director7205860001
    THOMAS, James David
    Parks Farm House
    Nanpantan Road
    LE11 3YE Loughborough
    Leics
    Administrateur
    Parks Farm House
    Nanpantan Road
    LE11 3YE Loughborough
    Leics
    EnglandBritishCompany Director69300620001
    THOMAS, James David
    60 Flood Street
    Chelsea
    SW3 5TE London
    Administrateur
    60 Flood Street
    Chelsea
    SW3 5TE London
    United KingdomBritishCompany Director24719510004
    VINER, Paul
    20 Denman Drive North
    NW11 6RB London
    Administrateur
    20 Denman Drive North
    NW11 6RB London
    BritishDirector117768960001
    WHITE, Shirley Janice
    16 Charnwood Fields
    Sutton Bonington
    LE12 5NP Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    16 Charnwood Fields
    Sutton Bonington
    LE12 5NP Loughborough
    Leicestershire
    BritishCompany Secretary,Director & C24512540001

    BEACON GAMING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 13 juil. 2000
    Livré le 15 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a 202 and 204 cricklewood broadway barnet.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 juil. 2000
    Livré le 15 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a carpark at the northern end of depot approach cricklewood broadway barnet.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 janv. 1996
    Livré le 07 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that land and buildings on the south side of weedon road, northampton, northamptonshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 1995
    Livré le 29 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at rear of 200-220 cricklewood broadway l/b of barnet.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 09 mai 1995
    Livré le 20 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of specific equitable charge all estates or interest in any f/h or l/h property (except the legally mortgaged property) now and at any time during the continuance of this security belonging to or charged to the company and/or the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lisa Michelle Crisp
    • James Simon Thomas
    • Carla Victoria Thomas
    • Barnett Waddingham Trustees Limited as Current Trustees and Other the Trustees from Time Totime of the Thomas Estates Limited Directors Discretionary Pension Scheme
    • Henry Simon Charles
    • James David Thomas
    • Alma June Thomas
    Transactions
    • 20 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 avr. 1995
    Livré le 18 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the north west side of baxter gate loughborough leics t/no LT174158.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 mars 1995
    Livré le 15 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC,
    Transactions
    • 15 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 21 juil. 1993
    Livré le 29 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40,213.50
    Brèves mentions
    All sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 29 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 juil. 1992
    Livré le 23 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that land and buildings on the southside of wedon road northampton northamptonshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0