BEACON GAMING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BEACON GAMING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01942151 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BEACON GAMING LIMITED ?
Adresse du siège social | Seebeck House 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Buckinghamshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BEACON GAMING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 déc. 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BEACON GAMING LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour BEACON GAMING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | GAZ2(A) | |||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 04 mars 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
État du capital | SH19 | |||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 déc. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Hamilton en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew James Hall en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 25 déc. 2011 | 8 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 17a/17B Market Place Loughborough Leicestershire LE113EA* le 06 mars 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin Hamilton le 01 nov. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Byron Evans en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Proctor en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Proctor en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 26 déc. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Brian Mattingley en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BEACON GAMING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire England |
| 93910510003 | ||||||||||
EVANS, Byron | Administrateur | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | England | English | Commercial Director | 140884750001 | ||||||||
HALL, Andrew James | Administrateur | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Finance Director | 30306840002 | ||||||||
HARDING, Nicholas Simon | Administrateur | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Chief Executive Officer | 150860820001 | ||||||||
CRANAGE, Sidney Derek | Secrétaire | Cranick Lodge 259a Nanpantan Road Nanpantan LE11 3YD Loughborough Leicestershire | British | 39964180001 | ||||||||||
MATTINGLEY, Brian | Secrétaire | 17a/17b Market Place Loughborough Leicestershire Le113ea | 150195950001 | |||||||||||
MURRAY, Stephanie | Secrétaire | 17a/17b Market Place Loughborough Leicestershire Le113ea | Australian | 123290920002 | ||||||||||
PROCTOR, Matthew Frederick | Secrétaire | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire England | 151171960001 | |||||||||||
VINER, Paul | Secrétaire | 20 Denman Drive North NW11 6RB London | British | Director | 117768960001 | |||||||||
WHITE, Shirley Janice | Secrétaire | 16 Charnwood Fields Sutton Bonington LE12 5NP Loughborough Leicestershire | British | 24512540001 | ||||||||||
CLARKE, John Thomas | Administrateur | 56 Salcombe Drive Glenfield LE3 8AF Leicester | British | Accountant | 38599630001 | |||||||||
CRANAGE, Sidney Derek | Administrateur | Cranick Lodge 259a Nanpantan Road Nanpantan LE11 3YD Loughborough Leicestershire | British | Director | 39964180001 | |||||||||
CRISP, John William Francis | Administrateur | Robins Nest Six Hills Road Walton On The Wolds Loughborough Leics | British | Company Director | 7205890001 | |||||||||
DIXON, Gillian | Administrateur | Croft House High Hesket CA4 0HS Carlisle Cumbria | United Kingdom | British | Commercial Director | 146371490001 | ||||||||
DUFFY, Patrick Michael Sario | Administrateur | 109 Sycamore Road East Leake LE12 6PR Loughborough Leicestershire | Irish | Company Director | 25179310001 | |||||||||
HAMILTON, Kevin | Administrateur | 1a Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Leisure | 147485660001 | ||||||||
HANNAH, Simon | Administrateur | 35 Turgis Road GU51 1EL Fleet Hampshire | United Kingdom | British | Director | 98633850001 | ||||||||
JEPP, Mark | Administrateur | 67 Humber Street DE65 5NW Hilton Derbyshire | England | British | Manager | 184171270001 | ||||||||
MATTINGLEY, Brian Roger | Administrateur | 17a/17b Market Place Loughborough Leicestershire Le113ea | United Kingdom | British | Chairman | 22417130002 | ||||||||
MURRAY, Stephanie | Administrateur | 17a/17b Market Place Loughborough Leicestershire Le113ea | England | Australian | Finance Director | 123290920002 | ||||||||
PROCTOR, Matthew Frederick | Administrateur | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire England | England | British | None | 136671560001 | ||||||||
THOMAS, Alma June | Administrateur | Parks Farm House Nanpantan Road LE11 3YE Loughborough Leics | British | Company Director | 7205860001 | |||||||||
THOMAS, James David | Administrateur | Parks Farm House Nanpantan Road LE11 3YE Loughborough Leics | England | British | Company Director | 69300620001 | ||||||||
THOMAS, James David | Administrateur | 60 Flood Street Chelsea SW3 5TE London | United Kingdom | British | Company Director | 24719510004 | ||||||||
VINER, Paul | Administrateur | 20 Denman Drive North NW11 6RB London | British | Director | 117768960001 | |||||||||
WHITE, Shirley Janice | Administrateur | 16 Charnwood Fields Sutton Bonington LE12 5NP Loughborough Leicestershire | British | Company Secretary,Director & C | 24512540001 |
BEACON GAMING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 13 juil. 2000 Livré le 15 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The l/h property k/a 202 and 204 cricklewood broadway barnet. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 13 juil. 2000 Livré le 15 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The l/h property k/a carpark at the northern end of depot approach cricklewood broadway barnet. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 17 janv. 1996 Livré le 07 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All that land and buildings on the south side of weedon road, northampton, northamptonshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 22 juin 1995 Livré le 29 juin 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land at rear of 200-220 cricklewood broadway l/b of barnet. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 09 mai 1995 Livré le 20 mai 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of specific equitable charge all estates or interest in any f/h or l/h property (except the legally mortgaged property) now and at any time during the continuance of this security belonging to or charged to the company and/or the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 07 avr. 1995 Livré le 18 avr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings on the north west side of baxter gate loughborough leics t/no LT174158. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 10 mars 1995 Livré le 15 mars 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Credit agreement | Créé le 21 juil. 1993 Livré le 29 juil. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £40,213.50 | |
Brèves mentions All sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 09 juil. 1992 Livré le 23 juil. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All that land and buildings on the southside of wedon road northampton northamptonshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0