EMOS RENTALS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEMOS RENTALS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01943058
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EMOS RENTALS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe EMOS RENTALS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Lennox
    Lennox Road
    RG22 4AP Basingstoke
    Hampshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EMOS RENTALS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LISCADELL LIMITED30 août 198530 août 1985

    Quels sont les derniers comptes de EMOS RENTALS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EMOS RENTALS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour EMOS RENTALS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de Spectrum House 8 Woodlands Business Village Coronation Road Basingstoke Hampshire RG21 4JX à The Lennox Lennox Road Basingstoke Hampshire RG22 4AP le 10 sept. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 août 2015

    État du capital au 21 août 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 sept. 2014

    État du capital au 10 sept. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 sept. 2013

    État du capital au 06 sept. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * the Lennox, Lennox Road Basingstoke Hampshire RG22 4AP* le 28 nov. 2012

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2010

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2009

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2008

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2007

    7 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2006

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de EMOS RENTALS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TILNEY, Marian Catherine
    2 Antrim Road
    Woodley
    RG5 3NR Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    2 Antrim Road
    Woodley
    RG5 3NR Reading
    Berkshire
    British100576270001
    TILNEY, David Leon
    2 Antrim Road
    Woodley
    RG5 3NR Reading
    Berkshire
    Administrateur
    2 Antrim Road
    Woodley
    RG5 3NR Reading
    Berkshire
    EnglandBritish100576260001
    EVANS, John Charles
    Clarendon Cottage The Orchard
    Naphill
    HP14 4QZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Clarendon Cottage The Orchard
    Naphill
    HP14 4QZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    British34249680001
    HARRISON, Colin Lancaster
    Wormald Park
    Grimshaw Lane
    M40 2WL Newton Heath
    Manchester
    Secrétaire
    Wormald Park
    Grimshaw Lane
    M40 2WL Newton Heath
    Manchester
    British44394290002
    TANKARD, Christopher Richard
    24 Nightingale Road
    Cheshunt
    EN7 6WD Waltham Cross
    Hertfordshire
    Secrétaire
    24 Nightingale Road
    Cheshunt
    EN7 6WD Waltham Cross
    Hertfordshire
    British59325710001
    BOGGESS, Jerry Reid
    671 South Ocean Boulevard
    Boca Raton
    Florida 33432
    Usa
    Administrateur
    671 South Ocean Boulevard
    Boca Raton
    Florida 33432
    Usa
    American68774400001
    BUCKLEY, John Clifford
    Wormald Park
    Grimshaw Lane Newton Heath
    M40 2WL Manchester
    Administrateur
    Wormald Park
    Grimshaw Lane Newton Heath
    M40 2WL Manchester
    Australian1436420002
    GUTIN, Irving
    1 Tyco Park
    Exeter
    New Hampshire
    03833
    Usa
    Administrateur
    1 Tyco Park
    Exeter
    New Hampshire
    03833
    Usa
    American49049420001
    JONES, Howard Lee
    7 The Ridings
    SL6 4LU Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    7 The Ridings
    SL6 4LU Maidenhead
    Berkshire
    British33514810001
    LEONARD, Peter Charles
    Tyco Park
    Grimshaw Lane, Newton Heath
    M40 2WL Manchester
    Administrateur
    Tyco Park
    Grimshaw Lane, Newton Heath
    M40 2WL Manchester
    British119805430001
    MOSS, Edmund Alfred
    Four Gables Village Road
    Denham
    UB9 5BN Uxbridge
    Middlesex
    Administrateur
    Four Gables Village Road
    Denham
    UB9 5BN Uxbridge
    Middlesex
    British35974760001
    NIXON, John
    Deep Waters
    Temple Gardens
    TW18 3NO Staines
    Middlesex
    Administrateur
    Deep Waters
    Temple Gardens
    TW18 3NO Staines
    Middlesex
    British71905840001
    ROGERS, David Jullian
    22 Nero Court
    Justin Close
    TW8 8QA Brentford
    Middlesex
    Administrateur
    22 Nero Court
    Justin Close
    TW8 8QA Brentford
    Middlesex
    British35974750001

    EMOS RENTALS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating charge
    Créé le 06 nov. 1995
    Livré le 11 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and security assignment
    Créé le 16 juin 1992
    Livré le 22 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease number 0007493 dated 8 june 1992
    Brèves mentions
    All the rights, title, benefit and interest of the company in and to the sub-leases granted by the company and whose lease reference numbers, dates of the leases and details appear in the contd sheet attached to the form 395.
    Personnes ayant droit
    • Baltic Industrial Supply Co. Limited
    Transactions
    • 22 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and security agreement
    Créé le 18 mars 1992
    Livré le 24 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease number 0007465 dated 14 december 1992, and all other monies payable arising out of or in connection with the exercise of any power or right granted by or by virtue of charge and security agreement
    Brèves mentions
    All the rights, title, benefit and interest of the company in and to the sub-leases granted by the company (for full details see form 395 and contd sheets).
    Personnes ayant droit
    • Baltic Industrial Supply Co LTD
    Transactions
    • 24 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and security assignment
    Créé le 01 oct. 1991
    Livré le 04 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of lease no 000 7344/000 7345 dated 25/9/91
    Brèves mentions
    All the right, title, benefit and interest of the company in and to the sub-leases as detailed in the continuation sheet attached to the form 395 relevant to this charge (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Baltic Industrial Supply Co LTD.
    Transactions
    • 04 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 oct. 1991
    Livré le 04 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and all or any of the subsidiaries (as defined)
    Brèves mentions
    (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Baltie Finance PLC and All or Any of the Subsidiaries (As Defined)
    Transactions
    • 04 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge & security assignment
    Créé le 09 avr. 1991
    Livré le 11 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of lease number 0006662 dated 26/2/91 and/or the charge
    Brèves mentions
    All the rights, title, benefit and interest of the company in and to the sub leases (see 395 & cont'd sheets for full details).
    Personnes ayant droit
    • Baltic Industrial Supply Co LTD.
    Transactions
    • 11 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and security assignment
    Créé le 23 janv. 1991
    Livré le 25 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of lease number 0006544/0006543
    Brèves mentions
    All the rights, title, benefit and interest of the company in and to the sub leases (see 395 and continuation sheets for full details).
    Personnes ayant droit
    • Baltic Industrial Supply Co. LTD
    Transactions
    • 25 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over security assignment
    Créé le 30 août 1990
    Livré le 05 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under agreement no 0006280 dated 17/7/90 and this charge
    Brèves mentions
    All the rights, title, benefit and interest of the company in and to the sub-leases (please see 395 M368C).
    Personnes ayant droit
    • Baltic Industrial Supply Company Limited
    Transactions
    • 05 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and security assignment
    Créé le 09 avr. 1990
    Livré le 20 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of agreement nos 8629 & 8630 dated 8/3/90
    Brèves mentions
    All the rights, tittle, benefit and interest of the company in and to the rule leases granted by the company (see 395 ref M103 and continuation sheets for full details of charge).
    Personnes ayant droit
    • Baltic Industrial Supply Company Limited.
    Transactions
    • 20 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge and security assignment
    Créé le 05 mars 1990
    Livré le 16 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All the rights title benefit and interest of the company in and to the sub-leases granted by the company and whose lease reference numbers dates of lease and details appear in the continuation sheets (please see M158 and continuationsheets for details).
    Personnes ayant droit
    • Baltic Industrial Supply Company Limited
    Transactions
    • 16 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0