CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED

CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01949119
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED ?

    • Assurance-vie (65110) / Activités financières et d'assurance
    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WELLINGTON UNDERWRITING HOLDINGS LIMITED20 sept. 198520 sept. 1985

    Quels sont les derniers comptes de CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG à 30 Finsbury Square London EC2A 1AG le 29 juin 2022

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    4 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 22 juin 2022

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Christopher John Read en tant qu'administrateur le 05 févr. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Richard Bradbrook en tant que directeur le 05 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Craig Standen en tant qu'administrateur le 17 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Juliet Phillips en tant que directeur le 17 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    13 pagesAA

    Cessation de la nomination de Paul Andrew Jardine en tant que directeur le 26 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Miss Juliet Phillips en tant qu'administrateur le 26 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Clynton Jacobus Luttig en tant qu'administrateur le 26 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REES, Marie Louise
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Secrétaire
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    201004350001
    LUTTIG, Clynton Jacobus
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritish218565170001
    READ, Christopher John
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritish267508980001
    STANDEN, Craig
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritish265497100001
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Secrétaire
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GUYATT, Elizabeth Helen
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    160260190001
    NOONE, Lisa Marie
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    British72182310002
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Secrétaire
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    British70960040001
    CATLIN (WELLINGTON) INSURANCE LIMITED
    Floor 3 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    6th
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor 3 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    6th
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement01321649
    100566440004
    AGNEW, Ian Charles
    9 Albert Place
    W8 London
    Administrateur
    9 Albert Place
    W8 London
    British6418620002
    ALEXANDER, John Lindsay, Sir
    Corton Denham House
    Corton Denham
    DT9 4LR Sherborne
    Dorset
    Administrateur
    Corton Denham House
    Corton Denham
    DT9 4LR Sherborne
    Dorset
    British6418630001
    AVERY, Julian Ralph
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    Administrateur
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    United KingdomUk37578750001
    BRADBROOK, Paul Richard
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    Administrateur
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United KingdomBritish148983260001
    BURKE, Martin Thomas
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    United KingdomIrish240344510001
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    CALLAN, Robert
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Administrateur
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish130365420001
    COOPER, Anthony Geoffrey
    Shirrenden
    Brenchley Road
    TN12 8DN Horsmonden
    Kent
    Administrateur
    Shirrenden
    Brenchley Road
    TN12 8DN Horsmonden
    Kent
    British73654090001
    CUSACK, Julian Michael
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    British84410430001
    DUMAS, Henry Raymond
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    Administrateur
    Coldharbour Farm
    BS30 5RJ Wick
    South Gloucestershire
    British73016630001
    FRESHWATER, Neil Andrew
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Administrateur
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish125646370001
    HAYNES, Joseph Antony
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Administrateur
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    British9580170001
    IBESON, David Christopher Ben
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Administrateur
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish52745170002
    JARDINE, Paul Andrew
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Administrateur
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish62337170003
    LETSINGER, Katherine Lee
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    Administrateur
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    United KingdomBritish54716770009
    MAYO, John William
    38 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    Administrateur
    38 Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5BD London
    British8271050001
    NORRIE, Guy Bainbridge, The Honourable
    Old Church Farm
    Broughton
    SO20 8AA Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    Old Church Farm
    Broughton
    SO20 8AA Stockbridge
    Hampshire
    British6420160001
    O'BRIEN, Christopher Patrick James
    66 Constable Road
    IP4 2UZ Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    66 Constable Road
    IP4 2UZ Ipswich
    Suffolk
    British78831780002
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Administrateur
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    British70960040001
    PETZOLD, Martin William
    The Pound
    Alfold
    GU6 Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    The Pound
    Alfold
    GU6 Cranleigh
    Surrey
    British12148870001
    PHILLIPS, Juliet
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    Administrateur
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United KingdomBritish211555110001
    PREBENSEN, Preben
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    Administrateur
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    United KingdomBritish137567870001
    PRENTICE, John Oscar
    Gentilshurst
    Fernhurst
    GU27 Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Gentilshurst
    Fernhurst
    GU27 Haslemere
    Surrey
    British8271070001
    PRIMER, Daniel Francis
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Administrateur
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomAmerican112177980002
    SINFIELD, Nicholas Christopher
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Administrateur
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish165481720002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Gracechurch Street
    EC3V 0BG London
    20
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5562639
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 11 déc. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 août 1998
    Livré le 27 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other beneficiaries (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 28 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 juil. 1997
    Livré le 29 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 03 nov. 1992
    Livré le 21 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 août 1988
    Livré le 18 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 08 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 août 1988
    Livré le 18 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 02 mars 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 déc. 1985
    Livré le 13 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See doc M10 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 30 déc. 1985
    Livré le 06 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Borrower's interest in the l/h properties etc and/or the proceeds of salethereof. Specific charge over all other securities etc the goodwill & uncalled capital etc floating charge undertaking and all property and assets present and future (see doc M9 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Baring Brothers & Co Limited
    Transactions
    • 06 janv. 1986Enregistrement d'une charge

    CATLIN UNDERWRITING (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 juin 2022Commencement of winding up
    02 juin 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0