LOMBARD ASSET LEASING LIMITED

LOMBARD ASSET LEASING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLOMBARD ASSET LEASING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01952037
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe LOMBARD ASSET LEASING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    135 Bishopsgate
    London
    EC2M 3UR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FIELDCHARM LIMITED02 oct. 198502 oct. 1985

    Quels sont les derniers comptes de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LOMBARD ASSET LEASING LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour LOMBARD ASSET LEASING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 nov. 2015

    État du capital au 05 nov. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Adam Holden en tant qu'administrateur le 11 mai 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Paul Gadsby en tant que directeur le 11 mai 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2014

    15 pagesAA

    Nomination de Mr Peter Edmund Lord en tant qu'administrateur le 27 févr. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nigel Timothy John Clibbens en tant que directeur le 27 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 oct. 2014

    État du capital au 31 oct. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes établis au 30 sept. 2013

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 nov. 2013

    État du capital au 20 nov. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * 3 Princess Way Redhill Surrey RH1 1NP* le 23 sept. 2013

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Andrew Paul Gadsby en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes établis au 30 sept. 2012

    19 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Barnard en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Rbs Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Qui sont les dirigeants de LOMBARD ASSET LEASING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Secrétaire
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC269847
    169073830001
    HOLDEN, Adam
    Elmwood Avenue
    TW13 7QD Feltham
    Smith House
    Middlesex
    England
    Administrateur
    Elmwood Avenue
    TW13 7QD Feltham
    Smith House
    Middlesex
    England
    EnglandBritishBank Official185018800001
    LORD, Peter Edmund
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    Administrateur
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishFinance House Manager195549570001
    BROMLEY, Heidi Elizabeth
    40 Hitchings Way
    RH2 8EW Reigate
    Surrey
    Secrétaire
    40 Hitchings Way
    RH2 8EW Reigate
    Surrey
    British33605720002
    CAMERON, Lindsey Helen
    The Terrace
    Glenlomond
    KY13 9HF Kinross
    Suite Gleann Cottage, 1
    Secrétaire
    The Terrace
    Glenlomond
    KY13 9HF Kinross
    Suite Gleann Cottage, 1
    Other132335590001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    DALY, Kirsty
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Secrétaire
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    160758120001
    EVANS, Margaret Janet
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    Secrétaire
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    British2289880001
    STRANAGHAN, Patricia Ann
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    Secrétaire
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    British39114460001
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Secrétaire
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    WILLIAMSON, Amy
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Secrétaire
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    166979420001
    WRAITH CARTER, Gillian
    8 Great Lime Kilns
    Southwater
    RH13 9JL Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    8 Great Lime Kilns
    Southwater
    RH13 9JL Horsham
    West Sussex
    British109333000001
    ASHWORTH, George Smith-Salmond
    2 Laurelsfield
    AL3 4BZ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Laurelsfield
    AL3 4BZ St Albans
    Hertfordshire
    EnglandEnglishBanker152638710001
    BALDOCK, Alexander David
    Westbourne Park Road
    W11 1EP London
    218
    United Kingdom
    Administrateur
    Westbourne Park Road
    W11 1EP London
    218
    United Kingdom
    United KingdomBritishBank Official132330380001
    BARNARD, Andrew David
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    Administrateur
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    EnglandBritishBank Official137736080001
    BEESTON, Alistair John
    Three Oaks Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Three Oaks Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    BritishBanker10670790001
    CARTE, Brian Addison
    Fairfield Lodge
    Hardwick Close Knott Park
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    Fairfield Lodge
    Hardwick Close Knott Park
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritishBanker/Governor Of Motability145559220001
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Administrateur
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director123744930001
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant49141230004
    FITCH, John Derek
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    Administrateur
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    BritishDirector & Gen Manager8461210001
    GADSBY, Andrew Paul
    London
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    Administrateur
    London
    EC2M 3UR London
    135 Bishopsgate
    England
    EnglandBritishBank Official74834980002
    HIGGINS, Peter
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    Administrateur
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    EnglandBritishFinance House Manager107984310001
    JOHNSON, Jeffrey
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    BritishAccountant103077710001
    KAPUR, Neeraj
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    Administrateur
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    United KingdomBritishBank Official122158360001
    KNOWLES, Christopher George
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    BritishBank Executive67501900002
    LYNAM, Paul Anthony
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    Administrateur
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    United KingdomIrishManaging Director100755360001
    MABERLY, Michael Alan
    Endellion
    Money Row Green Holyport
    SL6 2NA Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Endellion
    Money Row Green Holyport
    SL6 2NA Maidenhead
    Berkshire
    BritishFactor1288990001
    MARROW, Paul
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    Administrateur
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishBanker85771600001
    PEARCE, Nigel
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    Administrateur
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritishBanker63084840002
    POWELL, Martin Edward
    Monroe Station Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2DS Chelmsford
    Administrateur
    Monroe Station Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2DS Chelmsford
    United KingdomBritishDirector Risk & Regulation59795080001
    PRIESTMAN, Richard Mark
    31 Hove Park Villas
    BN3 6HH Hove
    Sussex
    Administrateur
    31 Hove Park Villas
    BN3 6HH Hove
    Sussex
    EnglandBritishChartered Accountant74412220002
    PURDY, John Douglas
    Kendals
    Little Heath Lane, Potten End
    HP4 2RY Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Kendals
    Little Heath Lane, Potten End
    HP4 2RY Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant68943220001
    ROOME, Harry Mccrea
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    Administrateur
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    EnglandBritishAccountant/Banker64898180001
    STUART, John David
    69 Howards Thicket
    SL9 7NU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    69 Howards Thicket
    SL9 7NU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishDirector76974710001
    SULLIVAN, Christopher Paul
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    Administrateur
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant/Banker67033830004

    LOMBARD ASSET LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of covenant
    Créé le 20 juil. 2001
    Livré le 26 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 4 of the recoveries agreement dated 12 july 1999 and/or the security assignment dated 12 july 1999 (all terms as defined)
    Brèves mentions
    All its right title and interest present and future in and to the vessel being the M.V. p&o nedlloyd cook registered under a certificate of british ships, official number 904689.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 26 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of a ship
    Créé le 20 juil. 2001
    Livré le 26 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 4 of the recoveries agreement dated 12 july 1999 and/or the security assignment dated 12 july 1999 (all terms as defined)
    Brèves mentions
    All of its interest in the the M.V. p&o nedlloyd cook registered under a certificate of british ships with official number 904689.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 26 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    First priority british statutory ship mortgage
    Créé le 19 sept. 2000
    Livré le 06 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All and any monies due or to become due in rebate of charterhire payable by the owner to the charterer pursuant to clauses 10.1.1(b), 15.8.2 and 16.3.10 of the charterparty and clause 4 of the dpp and any and all moneys liabilities actual or contingent present or future due owing payable or incurred from the company (as owner) to the chargee under the dpp, the deed of covenant, this mortgage and the lessor security assignment
    Brèves mentions
    64 sixty fourth shares in the ship "midnight merchant" registered on the british register with o/n;-903597 and it's appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Nedship Bank Nv
    Transactions
    • 06 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Lessor security assignment relating to "midnight merchant"
    Créé le 19 sept. 2000
    Livré le 02 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All and any monies by way of rebate of charterhire payable by the owner to the charterer pursuant to clauses 10.1.1(b), 15.8.2 and 16.3.10 of the charterparty and clause 4.1(c) of the dpp and any and all moneys liabilities and obligations (actual or contingent whether or not existing or hereafter arising, principal or surety, whether or not for the payment of money and any obligation or liability to pay damages) from the owner to the mortgagee (in it's capacity as security trustee) under the security documents.
    Brèves mentions
    All the company's rights title benefir and interest in and to a). The insurances and requisition compensation b). The security assignment and all payments to the company in respect thereof and all claims and rights arising therefrom. In relation to M.V. "midnight merchant". See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nedship Bank Nv
    Transactions
    • 02 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenant relating to "midnight merchant"
    Créé le 19 sept. 2000
    Livré le 02 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All and any monies by way of rebate of charterhire payable by the owner to the charterer pursuant to clauses 10.1.1(b), 15.8.2 and 16.3.10 of the charterparty and clause 4.1(c) of the dpp and any and all moneys liabilities and obligations (actual or contingent whether or not existing or hereafter arising, principal or surety, whether or not for the payment of money and any obligation or liability to pay damages) from the owner to the mortgagee (in it's capacity as security trustee) under the security documents.
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to the mortgaged property being roll on roll off cargo passenger vessel hull number 290 named "midnight merchant" and all parts engines boats and equipment and all other equiment leased otherwise thatn pursuant to the transaction documents and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nedship Bank Nv
    Transactions
    • 02 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    An accounts assignment
    Créé le 23 août 1999
    Livré le 25 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee all sums owing by the company by way of recoveries under or pursuant to a recoveries and loss sharing agreement dated 12TH july 1999 (the "recoveries and loss sharing agreement") in respect of a lease agreement dated 6TH july 1999 (the "lease")
    Brèves mentions
    The company's right title and interest present and future in and to interest-bearing deposit accounts denominated in sterling and dollars in the name of the company held with the national westminster bank PLC into which the company pays any net sales or total loss proceed in respect of the ship or any other moneys irrevocably and unconditionally received by the company,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 25 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of assignment
    Créé le 12 juil. 1999
    Livré le 22 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a recoveries and loss sharing agreement dated 12 july 1999
    Brèves mentions
    The company's right title and interest in and to the benefit of all insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 22 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Lessor mortgage and assignment
    Créé le 19 nov. 1997
    Livré le 20 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligation of the company to use reasonable endeavours to procure that the net sale proceeds resulting from a sale of the aircraft are, if paid to the company by a purchaser of the aircraft, paid directly into the proceeds account and the obligations of the company to pay rebates of rental to airtours international airways limited under clause 10.2.5 and clause 19.3 of the head lease agreement (the secured obligations)
    Brèves mentions
    One dassault falcon 900B aircraft with manufacturers serial number 165 and UK reg mark g-eves and all present and future rights titles and interest in the net proceeds of sale and the warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Colne Leasing Limited
    Transactions
    • 20 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0