MONTPELIER GROUP (EUROPE) LIMITED

MONTPELIER GROUP (EUROPE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMONTPELIER GROUP (EUROPE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01957940
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MONTPELIER GROUP (EUROPE) LIMITED ?

    • (6523) /
    • (6601) /

    Où se situe MONTPELIER GROUP (EUROPE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Saxon House
    Saxon Way
    GL52 6QX Cheltenham
    Gloucestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MONTPELIER GROUP (EUROPE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CADMANS (IFA) LIMITED04 janv. 199904 janv. 1999
    BRISKER COURT LIMITED20 sept. 199420 sept. 1994
    MARTIN CADMAN GROUP PLC01 nov. 198901 nov. 1989
    MARTIN CADMAN ASSOCIATES LIMITED20 mars 198620 mars 1986
    MOSSFORM LIMITED12 nov. 198512 nov. 1985

    Quels sont les derniers comptes de MONTPELIER GROUP (EUROPE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour MONTPELIER GROUP (EUROPE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    14 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 avr. 2017

    12 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Concorde House Trinity Park Solihull B37 7UQ à Saxon House Saxon Way Cheltenham Gloucestershire GL52 6QX le 07 juil. 2016

    1 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:re block transfer replacement of liq
    9 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 avr. 2016

    15 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 07 août 2015

    19 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 07 août 2014

    16 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de * Senate Recovery Limited 12a Church Street Warwick CV34 4AB* le 22 janv. 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 07 août 2013

    14 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 août 2012

    21 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    12 pages2.16B

    Résultat de la réunion des créanciers

    1 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    38 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de * Senate Recovery Limited 12a Church Street Warwick CV34 4AB* le 17 févr. 2012

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * Montpelier Court Barston Lane Barston Solihull West Midlands B92 0JP United Kingdom* le 14 févr. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Cessation de la nomination de Sara Vandervell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Graeham Sampson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 févr. 2011

    État du capital au 11 févr. 2011

    • Capital: GBP 823,432
    SH01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2009

    27 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Qui sont les dirigeants de MONTPELIER GROUP (EUROPE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAW, Trevor Ian
    Saxon Way
    GL52 6QX Cheltenham
    Saxon House
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Saxon Way
    GL52 6QX Cheltenham
    Saxon House
    Gloucestershire
    BritishIndependent Financial Adviser122932420001
    HARVEY, Madeleine Angela
    Saxon Way
    GL52 6QX Cheltenham
    Saxon House
    Gloucestershire
    Administrateur
    Saxon Way
    GL52 6QX Cheltenham
    Saxon House
    Gloucestershire
    United KingdomBritishFinancial Advisor26367670001
    LAW, Trevor Ian
    Saxon Way
    GL52 6QX Cheltenham
    Saxon House
    Gloucestershire
    Administrateur
    Saxon Way
    GL52 6QX Cheltenham
    Saxon House
    Gloucestershire
    EnglandBritishFinancial Advisor122932420001
    YELLOLY, David James
    Saxon Way
    GL52 6QX Cheltenham
    Saxon House
    Gloucestershire
    Administrateur
    Saxon Way
    GL52 6QX Cheltenham
    Saxon House
    Gloucestershire
    EnglandBritishFinancial Advisor37425950002
    GOODALL, David
    13 Chells Grove
    Kings Heath
    B13 0NA Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    13 Chells Grove
    Kings Heath
    B13 0NA Birmingham
    West Midlands
    British1490990001
    PATEL, Darsa Prashant
    5 Langland Drive
    HA5 4SA Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    5 Langland Drive
    HA5 4SA Pinner
    Middlesex
    British30630220001
    SCOTT, Clark
    19 Willesley Road
    LE65 2QA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Secrétaire
    19 Willesley Road
    LE65 2QA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    AustralianInsurance Agent33206490002
    CADMAN, Martin
    22 Fentham Road
    Hampton In Arden
    B92 0BB Solihull
    Administrateur
    22 Fentham Road
    Hampton In Arden
    B92 0BB Solihull
    EnglandBritishCompany Director23742900002
    COSTLEY-WHITE, Anthony Matthew
    Gardeners Lodge
    Wytham
    OX2 8QA Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Gardeners Lodge
    Wytham
    OX2 8QA Oxford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director33623640001
    LEASK, Graham Peter
    9 Copperkins Lane
    HP6 5QB Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    9 Copperkins Lane
    HP6 5QB Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Accountant94602090001
    SAMPSON, Graeham Stuart
    Barston Lane
    Barston
    B92 0JP Solihull
    Montpelier Court
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Barston Lane
    Barston
    B92 0JP Solihull
    Montpelier Court
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant129890600002
    SCOTT, Clark
    19 Willesley Road
    LE65 2QA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Administrateur
    19 Willesley Road
    LE65 2QA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    AustralianFinancial Advisor33206490002
    SCOTT, Mervyn
    30 Measham Road
    LE65 2PF Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Administrateur
    30 Measham Road
    LE65 2PF Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    AustralianCompany Director36512500001
    VANDERVELL, Sara Georgina Thompson
    Barston Lane
    Barston
    B92 0JP Solihull
    Montpelier Court
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Barston Lane
    Barston
    B92 0JP Solihull
    Montpelier Court
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompliance Director125593680001

    MONTPELIER GROUP (EUROPE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 févr. 2010
    Livré le 04 févr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Charge over cash deposits
    Créé le 01 sept. 2000
    Livré le 07 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All or any amounts at the date of the charge or from time to time deposited by or on behalf of the company to the credit of the account with the bank numbered 84133005 and any other current account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transactions
    • 07 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 janv. 1993
    Livré le 14 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement d/d 08/01/93
    Brèves mentions
    Ground floor 25A hanborough house hanborough business park oxford and brisker court 1685/1689 high street knowle solihull all stocks and shares all book and other debts floating security all the undertaking, and the goodwiil of the business (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Ascott General Services Limited
    Transactions
    • 14 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 04 juil. 1991
    Livré le 08 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all book debts and other debts. Floating charge on all the other. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 21 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 févr. 1990
    Livré le 20 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 21 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 nov. 1987
    Livré le 18 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from anthony matthew cosley white and/or johnathan william welfare and/or john kendall laurie and/or martin cadman and denton & co. Trustees limited as trustees of the oxford venture management directors pension scheme barclays bank PLC. To the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    2139 woodstock road oxfordshire title no on 28852.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1987Enregistrement d'une charge
    • 21 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 nov. 1987
    Livré le 18 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    213. woodstock road oxfordshire title no on 28852.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1987Enregistrement d'une charge
    • 21 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MONTPELIER GROUP (EUROPE) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 août 2012Administration ended
    02 févr. 2012Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Michael Pankhurst
    12a Church Street
    CV34 4AB Warwick
    Warwickshire
    practitioner
    12a Church Street
    CV34 4AB Warwick
    Warwickshire
    Jeremy Bowden
    12a Church Street
    CV34 4AB Warwick
    Warwickshire
    practitioner
    12a Church Street
    CV34 4AB Warwick
    Warwickshire
    2
    DateType
    08 août 2012Commencement of winding up
    19 mars 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Michael Pankhurst
    12a Church Street
    CV34 4AB Warwick
    Warwickshire
    practitioner
    12a Church Street
    CV34 4AB Warwick
    Warwickshire
    Jeremy Bowden
    12a Church Street
    CV34 4AB Warwick
    Warwickshire
    practitioner
    12a Church Street
    CV34 4AB Warwick
    Warwickshire
    Alisdair James Findlay
    Findlay James
    Saxon House
    GL52 6QX Saxon Way
    Cheltenham
    practitioner
    Findlay James
    Saxon House
    GL52 6QX Saxon Way
    Cheltenham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0