SYSTEMS TEAM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSYSTEMS TEAM LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01959626
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SYSTEMS TEAM LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SYSTEMS TEAM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SYSTEMS TEAM LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SYSTEMS TEAM BRISTOL LIMITED02 sept. 199702 sept. 1997
    MX BUSINESS SYSTEMS PLC06 sept. 199606 sept. 1996
    SYSTEMS TEAM PLUSMARK LIMITED30 sept. 199230 sept. 1992
    SYSTEMS TEAM DEVELOPMENT LIMITED05 févr. 198605 févr. 1986
    BELLKNOCK LIMITED15 nov. 198515 nov. 1985

    Quels sont les derniers comptes de SYSTEMS TEAM LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SYSTEMS TEAM LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SYSTEMS TEAM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    GAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 sept. 2013

    État du capital au 04 sept. 2013

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2013

    6 pagesAA

    Nomination de Ms Vinodka Murria en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Denise Williams en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Kerry Crompton en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Preedy en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neal Roberts en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Mrs Barbara Ann Firth en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul David Gibson en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* le 25 mars 2013

    2 pagesAD01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2013 au 28 févr. 2013

    3 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2012

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Richard Ian Preedy le 16 août 2012

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Richard Ian Preedy en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Neal Anthony Roberts le 16 mai 2012

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neal Anthony Roberts le 16 mai 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Kerry Jane Crompton le 16 mai 2012

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* le 14 mai 2012

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de SYSTEMS TEAM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176952900001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    BLACK, Samuel Colin
    Farfield Farm
    Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    Secrétaire
    Farfield Farm
    Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    British2814270004
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Secrétaire
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    BLACK, Samuel Colin
    Farfield Farm
    Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    Farfield Farm
    Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritish2814270004
    CAINES, John Michael
    1 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    1 Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish26293160002
    CAMPIN, Richard Michael
    Philbies
    Hardings Green, Cookham
    SL6 9NX Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Philbies
    Hardings Green, Cookham
    SL6 9NX Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish143673940001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish158261930001
    EVERSHED, Richard Albury
    49 Belle Vue Crescent
    Clifton
    BS8 4TF Bristol
    Administrateur
    49 Belle Vue Crescent
    Clifton
    BS8 4TF Bristol
    British64769170001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    FOWLER, Simon Richard
    Laburnum Cottage
    The Village
    GL18 2AJ Dymock
    Gloucestershire
    Administrateur
    Laburnum Cottage
    The Village
    GL18 2AJ Dymock
    Gloucestershire
    British77101900002
    ILES, Geoffrey
    Cider House
    Chewton Keynsham Keynsham
    BS31 2SS Bristol
    Avon
    Administrateur
    Cider House
    Chewton Keynsham Keynsham
    BS31 2SS Bristol
    Avon
    United KingdomBritish2814280004
    ILES, Geoffrey
    21 West Town Park
    Brislington
    BS4 5EA Bristol
    Avon
    Administrateur
    21 West Town Park
    Brislington
    BS4 5EA Bristol
    Avon
    British2814280001
    KROEGER, Peter
    3 Park Corner
    SL6 6PF Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    3 Park Corner
    SL6 6PF Maidenhead
    Berkshire
    British30322950001
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    LINTON, David Gibson
    The School House The Street
    Coaley
    GL11 5EB Dursley
    Gloucestershire
    Administrateur
    The School House The Street
    Coaley
    GL11 5EB Dursley
    Gloucestershire
    British52233990001
    LLOYD, Leslie Raymond
    1 Downesway
    SK9 7XB Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    1 Downesway
    SK9 7XB Alderley Edge
    Cheshire
    EnglandBritish2814290001
    MOORE, Richard John
    Dunelin
    2 Lee Avenue
    SL6 Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Dunelin
    2 Lee Avenue
    SL6 Maidenhead
    Berkshire
    British30322940001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PILECKA, Jolanta
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    United KingdomPolish90593990001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    VELUSSI, Luca
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    Administrateur
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    United KingdomItalian113413330003
    WHITFIELD, David
    Mortons St Johns Square
    GL14 3EX Cinderford
    Gloucestershire
    Administrateur
    Mortons St Johns Square
    GL14 3EX Cinderford
    Gloucestershire
    EnglandBritish44467350001
    WILLIAMS, Robert Charles
    28 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RL Bristol
    Administrateur
    28 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RL Bristol
    British68017980001

    SYSTEMS TEAM LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 oct. 2007
    Livré le 15 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transactions
    • 15 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 28 mai 1999
    Livré le 03 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 août 1993
    Livré le 13 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 avr. 1986
    Livré le 21 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 03 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 14 mars 1986
    Livré le 17 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the systems team group limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Including trade fixtures.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC.
    Transactions
    • 17 mars 1986Enregistrement d'une charge

    SYSTEMS TEAM LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2014Commencement of winding up
    05 nov. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0