FINDLATER MACKIE TODD & CO. LIMITED

FINDLATER MACKIE TODD & CO. LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFINDLATER MACKIE TODD & CO. LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01961485
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FINDLATER MACKIE TODD & CO. LIMITED ?

    • (5225) /

    Où se situe FINDLATER MACKIE TODD & CO. LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FINDLATER MACKIE TODD & CO. LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FINDLATER, MACKIE, TODD & CO LIMITED08 janv. 198708 janv. 1987
    HEATHBROAD PUBLIC LIMITED COMPANY19 nov. 198519 nov. 1985

    Quels sont les derniers comptes de FINDLATER MACKIE TODD & CO. LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 janv. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour FINDLATER MACKIE TODD & CO. LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:- re. Books & accounts
    1 pagesLIQ MISC RES

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 171 Victoria Street London SW1E 5NN le 26 juil. 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    4 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 juil. 2011

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 avr. 2011

    État du capital au 26 avr. 2011

    • Capital: GBP 610,500
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 janv. 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2009

    16 pagesAA

    Nomination de Ms Maria Luisa Cassoni en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Richard Mayfield en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Tina Reade en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 26 janv. 2008

    16 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2007

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 28 janv. 2006

    17 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de FINDLATER MACKIE TODD & CO. LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CASELY-HAYFORD, Margaret Henrietta Augusta
    171 Victoria Street
    SW1E 5NN London
    Secrétaire
    171 Victoria Street
    SW1E 5NN London
    BritishDirector Of Legal Services112989060001
    CASSONI, Maria Luisa
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritishFinance Director74583340001
    MAYFIELD, Richard
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritishDirector147295830001
    NEVILLE, Terence Frank
    171 Victoria Street
    SW1E 5NN London
    Secrétaire
    171 Victoria Street
    SW1E 5NN London
    British76180750002
    PARKER, Christopher Ronald
    Merrydown 6 Tanners Field
    Shalford
    GU4 8JW Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Merrydown 6 Tanners Field
    Shalford
    GU4 8JW Guildford
    Surrey
    British28580140001
    PRITCHARD, Brian James
    The Chase, Garden Close Lane
    Wash Common
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    The Chase, Garden Close Lane
    Wash Common
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    BritishChartered Secretary33530810002
    CLARKE, John Beverley
    The Old School House
    Bucklebury Village
    RG7 6PN Berkshire
    Administrateur
    The Old School House
    Bucklebury Village
    RG7 6PN Berkshire
    BritishDirector72875500001
    CLIFT, Paul Edwin
    171 Victoria Street
    SW1E 5NN London
    Administrateur
    171 Victoria Street
    SW1E 5NN London
    BritishDirector64300520002
    ESOM, Steven Derek
    171 Victoria Street
    SW1E 5NN London
    Administrateur
    171 Victoria Street
    SW1E 5NN London
    BritishDirector72699320004
    FALCONER, Peter
    Pennfields Penn Road
    HP9 2LS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pennfields Penn Road
    HP9 2LS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDir Of Buying Waitrose12956510001
    FELWICK, David Leonard
    Wood Farm Stables
    RG8 9SU Streatley
    Berkshire
    Administrateur
    Wood Farm Stables
    RG8 9SU Streatley
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector12932120001
    IMRIE, Joseph Gilmour
    Mead Cottage 29 Copse Mead
    Woodley
    RG5 4RP Reading
    Administrateur
    Mead Cottage 29 Copse Mead
    Woodley
    RG5 4RP Reading
    BritishHead Of Buying, Wait48534550001
    MARCH, Richard Murray
    Pinewood Cottage
    Pinewood Gardens
    GU19 5EP Bagshot
    Surrey
    Administrateur
    Pinewood Cottage
    Pinewood Gardens
    GU19 5EP Bagshot
    Surrey
    BritishAsst Director Research13442280001
    MEGSON, Angela
    Old Cottage
    Peppard Common
    RG9 5JE Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Old Cottage
    Peppard Common
    RG9 5JE Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishDirector112933670001
    PARKER, Christopher Ronald
    Merrydown 6 Tanners Field
    Shalford
    GU4 8JW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Merrydown 6 Tanners Field
    Shalford
    GU4 8JW Guildford
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director28580140001
    READE, Tina Sandra
    171 Victoria Street
    SW1E 5NN London
    Administrateur
    171 Victoria Street
    SW1E 5NN London
    EnglandBritishDirector75353930003
    ROWE, Christopher Jack Bristow, Mr.
    Roseland
    Rye Hill
    TN31 7NL Rye
    East Sussex
    Administrateur
    Roseland
    Rye Hill
    TN31 7NL Rye
    East Sussex
    EnglandBritishWine Merchant475360001
    TURNER, Jane Emma
    Flat 2
    2 Inverness Gardens
    W8 4RN London
    Administrateur
    Flat 2
    2 Inverness Gardens
    W8 4RN London
    BritishRetailer64241860001
    WILSON, David Mallon
    Magnolia Cottage 11 Hillside Road
    East Ewell
    KT17 3EH Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Magnolia Cottage 11 Hillside Road
    East Ewell
    KT17 3EH Epsom
    Surrey
    BritishChief Credit Manager13442290002
    YODA, Yoichi
    17-11 Shinjuko
    5 Chome
    FOREIGN Shinjuku-Ku
    Tokyo
    Japan
    Administrateur
    17-11 Shinjuko
    5 Chome
    FOREIGN Shinjuku-Ku
    Tokyo
    Japan
    JapaneseCompany Director28580150001

    FINDLATER MACKIE TODD & CO. LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of debt
    Créé le 27 nov. 1990
    Livré le 29 nov. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    £750,000 due from the royal bank of scotland (guernsey) limited to the company including all interest accrued or accruing in the future on the amount of the debt and all increases in the amount of the debt.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 oct. 1988
    Livré le 04 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h land & buildings k/a 22 great queen street kingsway holborn, l/b of camden greater london t/n ln 19466 fixed charge over plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures & fittings.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 05 janv. 1987
    Livré le 06 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Stocks shares other securities all intellectual property rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 12 févr. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FINDLATER MACKIE TODD & CO. LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 juil. 2011Commencement of winding up
    06 mai 2012Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0