GE CAPITAL CORPORATION (FUNDING) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GE CAPITAL CORPORATION (FUNDING) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01970191 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GE CAPITAL CORPORATION (FUNDING) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GE CAPITAL CORPORATION (FUNDING) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour GE CAPITAL CORPORATION (FUNDING) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 17 déc. 2021 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom à 1 More London Place London SE1 2AF le 04 janv. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Derek Carter en tant que directeur le 15 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 25 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 janv. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Key Leasing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 déc. 2019 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Ge Capital Corporation (Holdings) en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 déc. 2019 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Nomination de Oakwood Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire le 10 déc. 2019 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 25 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Derek Carter le 01 août 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 janv. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 22 pages | AA | ||||||||||
Cessation de Ge Capital Corporation (Property Company Investments) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 oct. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Notification de Ge Capital Corporation (Holdings) en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 oct. 2018 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Modification des détails de Ge Capital Corporation (Property Company Investments) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 août 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT le 17 août 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Zahra Peermohamed en tant que secrétaire le 19 juil. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Miss Zahra Peermohamed en tant que secrétaire le 01 mars 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GE CAPITAL CORPORATION (FUNDING) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secrétaire | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| GIRLING, Paul Stewart | Administrateur | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 225432580001 | |||||||||
| BAMBER, Janine Margaret | Secrétaire | 105 Shepperton Road N1 3DF London | British | 117898690002 | ||||||||||
| BEATTIE-JONES, Vanessa Avril | Secrétaire | 31 Wyndham Road KT2 5JR Kingston Upon Thames Surrey | British | 59539540002 | ||||||||||
| BROWN, Grace | Secrétaire | 35 Corringham Road Wembley Park HA9 9PX Wembley Middlesex | British | 102074060001 | ||||||||||
| COLLINS, John Wilfred James | Secrétaire | The Barn Chithurst Lane Trotton GU31 5ET Petersfield Hampshire | British | 2074480001 | ||||||||||
| EVANS, Fiona Maria | Secrétaire | 85 Ravensmede Way Chiswick W4 1TQ London | British | 49259690002 | ||||||||||
| GREEN, Pamela Anne | Secrétaire | 7 Belgravia Road St Johns WF1 3JP Wakefield West Yorkshire | British | 38435990009 | ||||||||||
| LEE, Tony | Secrétaire | 8 Rossdale TN2 3PG Tunbridge Wells Kent | British | 49293090003 | ||||||||||
| MEEHAN, Michael Anthony | Secrétaire | 260 Long Ridge Road FOREIGN Stamford Connecticut 06902 Usa | British | 15229820001 | ||||||||||
| ODDY, Louise Margaret | Secrétaire | 33 Tetcott Road SW10 0SB London | British | 56158480001 | ||||||||||
| PEERMOHAMED, Zahra | Secrétaire | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | 243694710001 | |||||||||||
| SLOCOMBE, Stephen Roy | Secrétaire | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | British | 55097590003 | ||||||||||
| WEISS, Beatrix Anna Margarita Parsons | Secrétaire | Meadow Cottage Hawksfold Lane GU27 3JW Fernhurst Surrey | British | 85529340001 | ||||||||||
| ABRAMSON, Christoffer | Administrateur | 37-39 Abingdon Road Flat 2 W8 6AH London | Swedish | 98463110005 | ||||||||||
| ALVAREZ, Mar | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark | United Kingdom | British / Spanish | 196497740001 | |||||||||
| ARDEN, Erica Anne | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | England | British | 183345020001 | |||||||||
| BAMBER, Janine Margaret, General Counsel, Uk | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 186173480001 | |||||||||
| BARNES, Robert Digby Phillips | Administrateur | Brampton Chase Summerhouse Road GU7 1PY Godalming Surrey | United Kingdom | British | 59539070002 | |||||||||
| BEATTIE-JONES, Vanessa Avril | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark | United Kingdom | British | 59539540002 | |||||||||
| BEATTIE-JONES, Vanessa Avril | Administrateur | 31 Wyndham Road KT2 5JR Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 59539540002 | |||||||||
| BOTHA, Stephanie | Administrateur | 5 Highbridge Wharf Highbridge SE10 9PS London | American | 116663740001 | ||||||||||
| BRIGGS, Malcolm George | Administrateur | 37 Henniker Gate CM2 6QH Chelmsford | British | 53177030001 | ||||||||||
| BRUNSBERG, Ellen | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | American | 63063460002 | |||||||||
| BURGER, Alec | Administrateur | 3 Adelade Road KT12 1NB Walton On Thames Surrey | British And American | 83634080006 | ||||||||||
| CARTER, Derek | Administrateur | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 225848070001 | |||||||||
| CASEY, Shay Andrew | Administrateur | Flat 3 St Mary Hall 106 Felsham Road SW15 1DQ London | United Kingdom | Irish | 90824990003 | |||||||||
| CHAMIDES, Ronald Harold | Administrateur | 12 Duck Road Place FOREIGN Wilton Connecticutt 060897 Usa | American | 30507910001 | ||||||||||
| CHIRLIAS, Alexandra Bahadour | Administrateur | 5 Allee Des Haubans, 91080 Courcouronnes France | French | 136959480001 | ||||||||||
| COLAO, Daniel Oreste | Administrateur | Flat 5 45 Queensgate Gardens SW7 5ND London | American | 52890580001 | ||||||||||
| COLLINS, Mark | Administrateur | 28 Cleveland Road Barnes SW13 0AB London | British | 56836220001 | ||||||||||
| CURTISS, Peter Hugh Bagot | Administrateur | 133 Haliburton Road St Margarets TW1 1PE Twickenham Middlesex | British | 24931180001 | ||||||||||
| DE BIE, Janet | Administrateur | 70 Franche Court Road SW17 0JU London | British | 105858010001 | ||||||||||
| DE BIE, Janet | Administrateur | 70 Franche Court Road SW17 0JU London | British | 105858010001 | ||||||||||
| DEL BEATO, Ilaria Jane | Administrateur | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 93124450002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GE CAPITAL CORPORATION (FUNDING) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key Leasing Limited | 10 déc. 2019 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ge Capital Corporation (Holdings) | 11 oct. 2018 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ge Capital Corporation (Property Company Investments) Limited | 06 avr. 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
GE CAPITAL CORPORATION (FUNDING) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Sub-charge and assignment | Créé le 06 juin 1997 Livré le 18 juin 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities of the company (in it's capacity as security trustee for the lenders in respect of, inter alia, the securities), under the terms of the finance documents (as defined in the charge), actual or contingent sole joint and/or several or otherwise to the chargee | |
Brèves mentions All the company's rights under and the benefit of the securities subsisting at the date of the sub-charge by way of legal mortgage and by way of assignment and transfer in connection with f/h land k/a centre city birmingham t/no;-WM76604 and f/h land k/a pearl house cardiff. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
GE CAPITAL CORPORATION (FUNDING) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0