MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED

MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01970801
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Tower Bridge House
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TAY HOMES (YORKSHIRE) LIMITED28 août 199228 août 1992
    TAY HOMES (NORTHERN) LIMITED30 sept. 198630 sept. 1986
    TAY HOMES (YORKSHIRE) LIMITED07 mars 198607 mars 1986
    ALVERHILL LIMITED13 déc. 198513 déc. 1985

    Quels sont les derniers comptes de MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Modification des coordonnées de l'administrateur Gavin Russell le 01 déc. 2015

    3 pagesCH01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 déc. 2015

    4 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 déc. 2014

    5 pages4.68

    Cessation de la nomination de Mark David Peters en tant que directeur le 14 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Gavin Russell en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stuart Leadill en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * Fourth Floor 130 Wilton Road London SW1V 1LQ* le 18 déc. 2013

    4 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    11 pagesAA

    Nomination de Stuart Kenneth Leadill en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Goldsmith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2013

    État du capital au 05 juin 2013

    • Capital: GBP 372,000,000
    SH01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2010

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    32 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2010

    15 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2009

    9 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul William Goldsmith le 01 avr. 2010

    3 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BNOMS LIMITED
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    Secrétaire
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    67896020002
    PRYCE, Colin Michael
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Administrateur
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    EnglandBritish,Jamaican67971010001
    RUSSELL, Gavin
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Administrateur
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritish188396180003
    BARTLETT, Paul Eugene
    Flat 3 Stable Mews
    Hillside Road
    AL1 3QR St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Flat 3 Stable Mews
    Hillside Road
    AL1 3QR St Albans
    Hertfordshire
    British54206450002
    EVANS, Stephen Geoffrey
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    British3621900001
    MCDONALD, Ross Edward
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    Secrétaire
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    British44092870001
    BANCROFT, Paul Andrew
    40 Cleveland Road
    Southwoodford
    E18 2AL London
    Administrateur
    40 Cleveland Road
    Southwoodford
    E18 2AL London
    EnglandBritish99625640001
    BILLINGHAM, Stephen Robert, Doctor
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Administrateur
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    British983300008
    COLES, John Howard
    7 Victoria Terrace
    Headingley
    LS6 4BE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    7 Victoria Terrace
    Headingley
    LS6 4BE Leeds
    West Yorkshire
    British4462250001
    DOUGLASS, Peter William
    Bleak House 1 School Lane
    Upper Poppleton
    YO2 6JS York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Bleak House 1 School Lane
    Upper Poppleton
    YO2 6JS York
    North Yorkshire
    British4462240001
    EVANS, Stephen Geoffrey
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Orchard
    58 Huddersfield Road Skelmanthorpe
    HD8 9AS Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish3621900001
    GALL, Terence
    232 Bradford Road
    WF1 2BA Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    232 Bradford Road
    WF1 2BA Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish37553160002
    GOLDSMITH, Paul William
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    Administrateur
    Fourth Floor
    130 Wilton Road
    SW1V 1LQ London
    EnglandBritish28639100003
    HENDERSON, Ronald Andrew
    Frankleigh
    Cedar Road
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    Administrateur
    Frankleigh
    Cedar Road
    GU22 0JH Woking
    Surrey
    United KingdomBritish2980400001
    HOWARD, Claire Lucie Mary
    Norsebury Cottage Winchester Road
    Micheldever
    SO21 3DG Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Norsebury Cottage Winchester Road
    Micheldever
    SO21 3DG Winchester
    Hampshire
    British54519060001
    KNIGHT, Dawn Elizabeth
    2 Temperance Street
    AL3 4QA St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Temperance Street
    AL3 4QA St Albans
    Hertfordshire
    British19935890001
    LEADILL, Stuart Kenneth
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Administrateur
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritish36282500001
    MARKHAM, Neal
    BD18
    Administrateur
    BD18
    British29216140001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Cob Cottage
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    West Sussex
    Administrateur
    Cob Cottage
    Shore Road
    PO18 8HZ Bosham
    West Sussex
    EnglandBritish34131020003
    MCDONALD, Ross Edward
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    Administrateur
    5b Vermont Road
    Upper Norwood
    SE19 3SR London
    British44092870001
    MCGLONE, Roy Vickers
    11 Pearces Orchard
    Fairmile
    RG9 2LF Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    11 Pearces Orchard
    Fairmile
    RG9 2LF Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    British45248290001
    MURRAY, Stuart Fraser
    29 Binden Road
    W12 9RJ London
    Administrateur
    29 Binden Road
    W12 9RJ London
    British675720001
    PARLOUR, John Leslie
    Red Roof Tithe Barn Lane
    Bardsey
    LS17 9DX Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Red Roof Tithe Barn Lane
    Bardsey
    LS17 9DX Leeds
    West Yorkshire
    British2494160001
    PEARSON, Christopher Rait O'Neill
    Shirley House, 5 West Walks
    DT1 1RE Dorchester
    Dorset
    Administrateur
    Shirley House, 5 West Walks
    DT1 1RE Dorchester
    Dorset
    British60365730001
    PETERS, Mark David
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    Administrateur
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower Bridge House
    United KingdomBritish192348430001
    STUBBS, Norman Alan
    East Chevin Road
    LS21 3DD Otley
    The Stables
    West Yorkshire
    Administrateur
    East Chevin Road
    LS21 3DD Otley
    The Stables
    West Yorkshire
    EnglandBritish1692650001
    TYSON, Christopher Roberto
    Pemberley Gregorys Meadow
    Stourscombe
    PL15 9QZ Launceston
    Cornwall
    Administrateur
    Pemberley Gregorys Meadow
    Stourscombe
    PL15 9QZ Launceston
    Cornwall
    British4093740001

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 24 août 1992
    Livré le 27 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and premises k/a 20 middlecroft road stourton grange middleton leeds west yorkshire t/n WYK254776. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 août 1992
    Livré le 22 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 14 ruffa lane pickering ryedale north yorkshire t/NNYK65314.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 août 1992
    Livré le 22 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 6 beck hill buttershaw north bierley bradford west yorkshire t/n WYK113069. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 août 1992
    Livré le 21 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 24 rayner avenue bradford west yorkshire and registered under t/n WYK287817. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 août 1992
    Livré le 20 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 28 teall court ossett wakefield west yorkshire t/n WYK89112. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 août 1992
    Livré le 20 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 1 cedar close scawby glanford humberside. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 juil. 1992
    Livré le 21 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fr/h land and blds--8 ringley meadows bempton,east yorkshire.t/no.hs 144650 fixed charge--all covenants and rights the plant,machinery,fixtures,fittings furniture....etc. See form 395.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 juil. 1992
    Livré le 09 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 10 victoria avenue filey scarborough north yorkshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 juil. 1992
    Livré le 14 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a sunnybank road mirfield west yorkshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 juil. 1992
    Livré le 07 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 178 wortley road high green sheffield south yorkshire t/n SYK430. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 juil. 1992
    Livré le 07 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 9 highfield road north thorseby east lindsey lincolnshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juil. 1992
    Livré le 04 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 10 fern road walkley sheffield south yorkshire t/n YWE22948. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juil. 1992
    Livré le 04 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 20 kingsdale avenue drighlington leeds west yorkshire. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juin 1992
    Livré le 02 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold land and blds--91 carr rd, calverley,leeds,west yorkshire. T/no.wyk 417667. fixed charge--the benefit of all covenants and rights......the plant, machinery,fixtures,fittings,furniture, equipment,implements and utensils now and in the future.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 juin 1992
    Livré le 30 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land and blds--8 haigh side driverothwell,leeds,west yorkshire.t/no.wyk 114469 fixed charge--the benefit of all covenants and rights,the plant,machinery fixtures,fittings,furniture,equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 juin 1992
    Livré le 30 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land and blds--29 nab wood terrace,shipley,bradford,west yorkshire t/no.wyk 42418 fixed charge--the benefit of all covenants and rights,the plant,machineryfixtures,fittings,furniture,equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 juin 1992
    Livré le 20 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h land and premises k/a 20 southwold scarborough N. yorks. Inc: fixtures and fittings (see form 395).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 juin 1992
    Livré le 20 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h land and buildings k/a 34 siver royd road wortley leeds W.yorks title no: WYK413215 inc: fixtures and fittings (see form 395).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 17 juin 1992
    Livré le 19 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and blds--5 mere view gardens scarborough,north yorkshire fixed charge--all covenants and rights...,..the plant,machinery,fixtures,fittings,furniture...etc.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 mai 1992
    Livré le 22 mai 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 5 manor close long street topcliffe hambleton north yorkshire t/n NYK54632. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 06 mai 1992
    Livré le 08 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 50 lidget lane skelmanthorpe kirklees west yorkshire t/n WYK75281. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 mai 1992
    Livré le 08 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 140 quaker lane cleckheaton kirklees west yorkshire t/n wyk 335778. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 mai 1992
    Livré le 07 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 21 ackroyd street morley leeds west yorkshire t/n wyk 84243. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 avr. 1992
    Livré le 29 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    3 pumping station cottages,dunswell lanebeverley,humberside.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 avr. 1992Enregistrement d'une charge
    • 19 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 avr. 1992
    Livré le 08 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings k/a 6 carr lane tankersley barnsley south yorkshire t/n SYK41703. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MAYFAIR PLACE INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 déc. 2013Commencement of winding up
    05 janv. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Roderick John Weston
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0