CBS PRIVATE CAPITAL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CBS PRIVATE CAPITAL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01973039 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CBS PRIVATE CAPITAL LIMITED ?
| Adresse du siège social | Unit C25 Jacks Place 6 Corbet Place E16NN London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CBS PRIVATE CAPITAL LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour CBS PRIVATE CAPITAL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2010 avec liste complète des actionnaires | 12 pages | AR01 | ||||||||||
Annulation d'actions. État du capital au 16 juin 2010
| 4 pages | SH06 | ||||||||||
État du capital au 12 févr. 2010
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 4 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 4 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2008 | 14 pages | AA | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 190 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 353 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2007 | 15 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2006 | 16 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CBS PRIVATE CAPITAL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOX, Andrew Staley | Secrétaire | 4 Dukes Road RH16 2JH Haywards Heath West Sussex | British | 43073160004 | ||||||
| EWART, David John | Administrateur | Courthill House Potterne SN10 5PN Devizes Wiltshire | United Kingdom | British | 23635320001 | |||||
| FOX, Andrew Staley | Administrateur | 4 Dukes Road RH16 2JH Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | 43073160004 | |||||
| HARBORD-HAMOND, Charles Anthony Assheton | Administrateur | 45 Alderbrook Road SW12 8AD London | United Kingdom | British | 56874210004 | |||||
| CLARKE, Jeanette Mary | Secrétaire | St Mary's Place Little Dunmow CM6 3HX Dunmow 12 Essex | British | 14954830002 | ||||||
| CRAWFORD SMITH, Neil Leslie | Secrétaire | 11 Manor Rise ME14 4DB Bearsted Kent | British | 97197960001 | ||||||
| HERBERT, David Ian John | Secrétaire | 18 Leys Road CB4 2AT Cambridge Cambridgeshire | British | 2215730002 | ||||||
| MCMULLEN, Gerald Phipps | Secrétaire | Little Broomhall Warnham RH12 3PA Horsham West Sussex | British | 19668600001 | ||||||
| PENDER, Charles Christopher Tresilian | Secrétaire | 66 Fentiman Road SW8 1LA London | British | 63509920002 | ||||||
| ROBERTS, Ian Paul Hartin | Secrétaire | The Old Dairy Pennington Road TN4 0SH Southborough Kent | British | 73221640001 | ||||||
| THORNHILL, Nicholas Anthony | Secrétaire | 97 Carmel Court Kings Drive HA9 9JG Wembley Middlesex | British | 44310170001 | ||||||
| YOUNG, Mark Halifax Graham | Secrétaire | 22 Arundel Road TN1 1TB Tunbridge Wells Kent | English | 36018280001 | ||||||
| AVERY, Julian Ralph | Administrateur | Little Boarzell Hurst Green TN19 7QU Etchingham East Sussex | United Kingdom | Uk | 37578750001 | |||||
| BARR, Alan Francis | Administrateur | Great Noven Farm North Chailey Lewes Sussex | British | 23882050001 | ||||||
| BENNETT, Fiona Marie Therese | Administrateur | 29 Little Adelphi 10 John Adam Street WC2N 6HA London | British | 39511970004 | ||||||
| BERKELEY, Giles Robert | Administrateur | Rookery Farm House Ramsdean GU32 1RU Petersfield Hampshire | United Kingdom | British | 115871140001 | |||||
| BRUCE, Timothy Robertson | Administrateur | The Old Rectory Combs IP14 2JS Stowmarket Suffolk | British | 9060480001 | ||||||
| CARR, Julian Anthony Robie | Administrateur | Gulsons Farm Boxted CO4 5SX Colchester Essex | United Kingdom | British | 22515800001 | |||||
| CASTELL, Andrew Sean | Administrateur | 13 Chantry Street N1 8NR London | British | 85990150001 | ||||||
| CRAWFORD-SMITH, Neil Leslie | Administrateur | 11 Manor Rise Bearsted ME14 4DB Maidstone Kent | England | British | 65236570001 | |||||
| DAMBRUMENIL, Nicholas John | Administrateur | 3 West Halkin Street Belgrave Square SW1 8JJ London | British | 52075430001 | ||||||
| DOYLE, Jennifer Susan Caroline | Administrateur | 11 Palace Gardens IG9 5PQ Buckhurst Hill Essex | England | British | 97497990001 | |||||
| FLETCHER, Robert Morley | Administrateur | 68 Warwick Way SW1V 1RZ London | British | 23882060001 | ||||||
| HALDANE, James Martin | Administrateur | Gleneagles PH3 1PJ Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 745050003 | |||||
| HARRIS, Anthony David | Administrateur | 58 Clarendon Road Kensington W11 2HL London | British | 10827840001 | ||||||
| HERBERT, David Ian John | Administrateur | 18 Leys Road CB4 2AT Cambridge Cambridgeshire | British | 2215730002 | ||||||
| HERBERT, David Ian John | Administrateur | 18 Leys Road CB4 2AT Cambridge Cambridgeshire | British | 2215730002 | ||||||
| HOLBECH, Timothy Hugh | Administrateur | 64 Geraldine Road SW18 2NL London | British | 19390190001 | ||||||
| HOLMES, Kenneth | Administrateur | 20 Hampstead Gardens SS5 5HN Hockley Essex | British | 22860910001 | ||||||
| HUSSEY, Andrew David | Administrateur | Rye Mill House Feering CO5 9SB Colchester | British | 40669110001 | ||||||
| ILLINGWORTH, James Le Tall | Administrateur | 9 Ennismore Avenue Chiswick W4 1SE London | British | 51360900001 | ||||||
| IRONSIDE, Charles Edmund Glanville, The Hon | Administrateur | 30 Marmion Road SW11 5PA London | British | 59893980002 | ||||||
| JEFFERIES, Jane Anne | Administrateur | 29 Fryerning Lane CM4 0DD Ingatestone Essex | British | 65589390001 | ||||||
| KEELING, Christopher Anthony Gedge | Administrateur | Leyden House Thames Bank Mortlake SW14 7QR London | British | 7797040001 | ||||||
| LEE, Michael Alan | Administrateur | 4 Wilona Avenue North Sydney FOREIGN Nsw 2060 Australia | Australian | 92794500001 |
CBS PRIVATE CAPITAL LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A master assignment of auction agreements | Créé le 25 août 1999 Livré le 02 sept. 1999 | En cours | Montant garanti All moneys liabilities and other obligations due or to become due from the company to the chargee under a facility letter dated 7 july 1999 and on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the company's rights title and interest in and to,in relation to each name,the document entitled "authorities,acknowledgements and agreements relating to mapa capacity and participation in 1999 capacity auctions".. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0