CARREFOUR PROPERTIES LIMITED

CARREFOUR PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARREFOUR PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 01974382
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARREFOUR PROPERTIES LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe CARREFOUR PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARREFOUR PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BREDLIGHT LIMITED31 déc. 198531 déc. 1985

    Quels sont les derniers comptes de CARREFOUR PROPERTIES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le04 janv. 2011
    Date d'échéance des prochains comptes04 oct. 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 janv. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour CARREFOUR PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Certificat d'immatriculation d'une société de secours mutuel

    pagesCERTIPS

    Divers

    Forms b and z to convert to I & ps
    pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to i&ps 22/09/2010
    RES13

    Nomination de Stephen Parry en tant que secrétaire

    pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 sept. 2010

    État du capital au 09 sept. 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2010

    pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Humes le 01 août 2010

    pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Hurrell le 01 août 2010

    pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 mai 2009

    pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 25 avr. 2010 au 04 janv. 2010

    pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ le 20 nov. 2009

    pagesAD01

    Cessation de la nomination de William Robson en tant que directeur

    pagesTM01

    Nomination de Mrs Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire

    pagesAP03

    Cessation de la nomination de Emily Martin en tant que secrétaire

    pagesTM02

    legacy

    pages363a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288a

    legacy

    pages288b

    legacy

    pages288a

    Comptes établis au 26 avr. 2008

    pagesAA

    legacy

    pages363a

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re dividend 13/02/08
    RES13

    Comptes établis au 28 avr. 2007

    pagesAA

    legacy

    pages363a

    Qui sont les dirigeants de CARREFOUR PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PARRY, Stephen
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    154310540001
    SELLERS, Caroline Jane
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    Greater Manchester
    United Kingdom
    146919380001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish99724260001
    BROWN, Michael Alfred
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    British50692920001
    EGITTO, Joleen
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    Secrétaire
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    British61599540001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    GRANT, Stephen Martin
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Secrétaire
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    British91828160006
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    Secrétaire
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    British115285710001
    ASHTON, Yvonne Margaret
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    Administrateur
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    British45225070002
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Administrateur
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritish85825120001
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritish74956170001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    Administrateur
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    British111624590001
    COATES, Philip Raymond
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    Administrateur
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    United KingdomBritish60114990002
    COOPER, Geoffrey Ian
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    Administrateur
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    British59071930001
    GATTO, Salvatore Martin
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    Administrateur
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    United KingdomBritish37327260002
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    HARTE, Damien Bernard
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    Administrateur
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    British33922420001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    Administrateur
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    British91828160003
    MITCHELL INNES, Alistair Campbell
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    British1386650001
    NELLIST, Robert Henry Harger
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    British5435750001
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritish57803420002
    SHARP, Ernest Henry
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    Administrateur
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    British777200001
    SMITH, Neil Reynold
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    Administrateur
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    British61599510002

    CARREFOUR PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and debenture
    Créé le 05 juil. 1993
    Livré le 16 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company each other group company(as defined) and any other present or future subsidiary of gateway group limited(as defined) to the chargees under the terms of each of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co.Limitedas Agent and Trustee for the Banks
    Transactions
    • 16 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 05 juil. 1993
    Livré le 15 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to samuel montagu & co. Limited as agent and trustee for the lenders (as defined therein) in respect of the guarantee and debenture dated 25TH october 1989 as amended by the supplemental deed dated 5TH july 1993
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transactions
    • 15 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 25 oct. 1989
    Livré le 31 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    (For full details see certificate)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • S. G. Warburg & Co Ltdas Agent and Trustee for Itself and for Each Lender (As Defined Herein)
    Transactions
    • 31 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 13 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0