LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED

LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01974805
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NATWEST LEASING INDUSTRIES LIMITED13 juil. 199013 juil. 1990
    LOMBARD LEASING INDUSTRIES LIMITED22 avr. 198622 avr. 1986
    HARPBUY LIMITED03 janv. 198603 janv. 1986

    Quels sont les derniers comptes de LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD02

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de 25 Gresham Street London EC2V 7HN à 1 More London Place London SE1 2AF le 23 janv. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 déc. 2016

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Colin Graham Dowsett en tant que directeur le 16 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2015 au 30 juin 2016

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juin 2016

    État du capital au 06 juin 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Kevin Charles Harris en tant que directeur le 30 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Robert Turner en tant qu'administrateur le 23 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 juin 2015

    État du capital au 02 juin 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin Charles Harris le 06 mars 2015

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    1 pagesAD02

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 juin 2014

    État du capital au 04 juin 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Sharon Slattery en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Lloyds Secretaries Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Robin Isaacs en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Colin Graham Dowsett en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02791894
    73512200003
    TURNER, John Robert
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish76185650001
    BLACK, Nicola Suzanne
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British52160130002
    BUTLIN, Rachel Elizabeth
    44 Stopher House
    Webber Street
    SE1 0SE London
    Secrétaire
    44 Stopher House
    Webber Street
    SE1 0SE London
    British5966810002
    LEWIS, Sally Elizabeth
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    Secrétaire
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    British4807180001
    SLATTERY, Sharon Noelle, Mrs.
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Irish45487120004
    BAILEY, Richard James
    17 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    Administrateur
    17 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    British37824840001
    BARTON-SMITH, Colim
    Barn Mead Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Barn Mead Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    British23187320002
    BASING, Anthony Mark
    36 Selwyn Crescent
    AL10 9NN Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    36 Selwyn Crescent
    AL10 9NN Hatfield
    Hertfordshire
    British99221710001
    BULL, Richard Piers Ashworth
    The Otter 16 Brindley Quays
    Braunston
    NN11 7AN Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    The Otter 16 Brindley Quays
    Braunston
    NN11 7AN Daventry
    Northamptonshire
    British34371520003
    CARPENTER, Paul
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    Administrateur
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    United KingdomBritish53756030002
    COOKE, Timothy John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish120834610001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish46297770002
    CUMMING, Andrew John
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    Administrateur
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    United KingdomBritish46297770002
    DAVIES, John Anthony
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British32423210001
    DAVY, Philip Maturin
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    Administrateur
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    EnglandBritish96202910001
    DENT, Nicholas Michael
    78a Wendover Road
    TW18 3DD Egham
    Surrey
    Administrateur
    78a Wendover Road
    TW18 3DD Egham
    Surrey
    British43922780001
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish152332230001
    FOAD, Allan Robert
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    Administrateur
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    British40761160001
    GRANT, Mark Andrew
    Silverdale Avenue
    KT12 1EL Walton-On-Thames
    177
    Surrey
    Administrateur
    Silverdale Avenue
    KT12 1EL Walton-On-Thames
    177
    Surrey
    United KingdomBritish236442470001
    GREEN, Michael Jonathan
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    Administrateur
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    EnglandBritish141461000001
    HARRIS, Kevin Charles
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    United KingdomBritish170091040001
    HARRISON, David Henry Arnold
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    UkBritish8949580001
    HENDERSON CLELAND, Hugh John
    6 Steep Hill
    Streatham
    SW16 1UL London
    Administrateur
    6 Steep Hill
    Streatham
    SW16 1UL London
    British57536880001
    HERBERT, Jon Mark
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish203539400001
    HIGGINS, Peter
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    Administrateur
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    EnglandBritish107984310001
    HILLIARD, Adrian Richard
    50 Old Shoreham Road
    Portslade
    BN41 1SN Brighton
    Sussex
    Administrateur
    50 Old Shoreham Road
    Portslade
    BN41 1SN Brighton
    Sussex
    British49021840001
    HING, Allen Peter
    59 Woodbastwick Road
    Sydenham
    SE26 5LG London
    Administrateur
    59 Woodbastwick Road
    Sydenham
    SE26 5LG London
    British11403910001
    ISAACS, Robin Alexander
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish115548350001
    JOSEPH, Michael William
    The Hermitage
    St Leonards
    HP23 6NW Tring
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Hermitage
    St Leonards
    HP23 6NW Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish44954410002
    KEIGHLEY, Peter Thomas
    36 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AD Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    36 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AD Waltham Cross
    Hertfordshire
    British43234170001
    KING, Roger Steuart
    9 Kingfisher House
    No 6 Melbury Road
    W14 8LN London
    Administrateur
    9 Kingfisher House
    No 6 Melbury Road
    W14 8LN London
    United States Citizen79713690002
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Administrateur
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    British41327480001
    PASHLEY, Robert Lawrence
    Apartment 29d
    145 East 48th Street
    FOREIGN New York Usa
    Ny 10017
    Administrateur
    Apartment 29d
    145 East 48th Street
    FOREIGN New York Usa
    Ny 10017
    British34481270003
    PELLY, Richard Fowler
    126 Dora Road
    Wimbledon
    SW19 7HJ London
    Administrateur
    126 Dora Road
    Wimbledon
    SW19 7HJ London
    EnglandBritish99868440002

    LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Amended and restated intercreditor agreement
    Créé le 19 déc. 1997
    Livré le 31 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of chase manhattan international limited as security agent and trustee for the senior creditors (as defined) and the lessors (as defined) (1)the senior debt, subject to clause 11.2, clause 11.4, clause 27.3(iii) and clause 27.4(b) of the intercreditor agreement all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents (as defined), (2)the lease debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the lessors under or in connection with the lease finance documents (as defined) and (3) the subordinated debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the subordinated creditors (as defined) under or in connection with the subordinated debt documents or in connection with treasury debt and all indemnity rights
    Brèves mentions
    If at any time prior to the later of the senior discharge date the company receives a payment or distribution in cash or kind of or on account of any lease debt or prior to the senior discharge date any lease debt is discharged in each case in a manner not permitted by clause 6 (permitted lease payments) by clause 7 (permitted subordinated payments) or clause 15.1 (permitted lease enforcement) clause 15.2 (permitted enforcement action in respect of vat) or by clause 17 (proceeds of enforcement of security) the company will subject to clause 10.9 (exclusion of trust) hold such recovery payment distribution proceeds set-off or other amount in trust for the security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited
    Transactions
    • 31 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 21 déc. 1995
    Livré le 05 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under this chattel mortgage and under and in accordance with clause 4 (sales representative) of the lessor direct agreement (as defined)
    Brèves mentions
    First fixed charge all rights title and interest in and to the english equipment (other than any software licences); the english sale proceeds and all moneys (including interest) standing to the credit of the sale proceeds account and the debt(s) represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bank, N.A.as Agent and Trustee for the Senior Creditors (As Defined)
    Transactions
    • 05 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Intercreditor agreement (the "intercreditor agreement")
    Créé le 21 déc. 1995
    Livré le 05 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    (A) the senior debt, (b) the lease debt and (c) the subordinated debt (all as defined in the intercreditor agreement)
    Brèves mentions
    If at any time prior to the senior discharge date the lessor receives a payment or distribution in cash or in kind of or on account of any lease debt such debt shall be held in trust for security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bank N.A.as Security Agent and Trustee for the Senior Creditors and the Lessor
    Transactions
    • 05 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 déc. 2016Commencement of winding up
    13 févr. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0