R.T. MASTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéR.T. MASTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01981078
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de R.T. MASTS LIMITED ?

    • (3220) /

    Où se situe R.T. MASTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de R.T. MASTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CASTLECO (105) LIMITED22 janv. 198622 janv. 1986

    Quels sont les derniers comptes de R.T. MASTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour R.T. MASTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 mars 2010

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 déc. 2009

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages403a

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 déc. 2008

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    5 pages395

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    21 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages225

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    5 pages288a

    legacy

    5 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de R.T. MASTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOLLIDAY, Peter John
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director73600480004
    CLARKE, James Stuart
    3 Burlington Road
    Birkdale
    PR8 4RX Southport
    Administrateur
    3 Burlington Road
    Birkdale
    PR8 4RX Southport
    BritishCompany Director79483030004
    CLARKE, James
    Silvertrees 98 Victoria Road
    Formby
    L37 1LP Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    Silvertrees 98 Victoria Road
    Formby
    L37 1LP Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishCompany Director122650860001
    HOLLIDAY, Peter John
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Woodlands
    86 Hollin Lane Styal
    SK9 4JJ Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director73600480004
    BYRNES, Anthony James
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    Secrétaire
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    BritishDirector68917030002
    CHEANEY, Bryan
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Secrétaire
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    British3450590001
    DENNEHY, Angela Mary
    Holmwood Leamington Road
    WR12 7EB Broadway
    Worcestershire
    Secrétaire
    Holmwood Leamington Road
    WR12 7EB Broadway
    Worcestershire
    British53952890001
    ELLISON, John Beaumont
    25a High Street
    GU19 5AF Bagshot
    Surrey
    Secrétaire
    25a High Street
    GU19 5AF Bagshot
    Surrey
    BritishCompany Secretary93434850001
    GREEN, Natalie Ursula
    8 Birkdale Close
    NN2 7PD Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    8 Birkdale Close
    NN2 7PD Northampton
    Northamptonshire
    British55480450001
    GREW, Christopher Adam
    15 Noel Road
    Islington
    N1 8HQ London
    Secrétaire
    15 Noel Road
    Islington
    N1 8HQ London
    British40188850002
    HALL, Graeme Andrew
    4 Roman Close
    Weldon
    NN17 3JA Corby
    Northamptonshire
    Secrétaire
    4 Roman Close
    Weldon
    NN17 3JA Corby
    Northamptonshire
    British66755120001
    LADHA, Alnoor
    59 Williamson Way
    WD3 8GL Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    59 Williamson Way
    WD3 8GL Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishSolicitor89311330001
    PERKINS, William Robert
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishManaging Director3450600001
    WONG, Thomas Chow Woei
    22 Hatchgate Gardens
    Burnham
    SL1 8DD Slough
    Berkshire
    Secrétaire
    22 Hatchgate Gardens
    Burnham
    SL1 8DD Slough
    Berkshire
    MalaysianCompany Secretary75111230001
    ANTONIUCCI, Pier Giorgio
    17474 Pleasant View Avenue
    Monte Sereno
    95030 California
    Usa
    Administrateur
    17474 Pleasant View Avenue
    Monte Sereno
    95030 California
    Usa
    AmericanPresident56303650001
    BYRNES, Anthony James
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    Administrateur
    73 Edge Lane
    Stretford
    M32 8PA Manchester
    United KingdomBritishDirector68917030002
    CHEANEY, Bryan
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    Administrateur
    9 Kettering Road
    Isham
    NN14 1HQ Kettering
    Northamptonshire
    BritishFinancial Director3450590001
    COLLINS, Robert
    1473 Los Rios Drive
    San Jose, California, 95120
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    1473 Los Rios Drive
    San Jose, California, 95120
    FOREIGN Usa
    AmericanExecutive67233600001
    COPLEY, Stephen Gerald
    The Croft Banbury Road
    Ladbroke
    CV47 2BY Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    The Croft Banbury Road
    Ladbroke
    CV47 2BY Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director99105730001
    CROFTS, Paul Nicholas
    1 College Gardens
    PE15 8LF March
    Cambridgeshire
    Administrateur
    1 College Gardens
    PE15 8LF March
    Cambridgeshire
    BritishDirector105233500001
    DORAN, Michael John
    Hope Cottage
    Ashorne
    CV35 9DR Warwick
    Administrateur
    Hope Cottage
    Ashorne
    CV35 9DR Warwick
    EnglandBritishDirector81077000001
    GEORGE, Alan Stanley
    4 Woodbine Street
    CV32 5BG Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    4 Woodbine Street
    CV32 5BG Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector53459730002
    HARRIS, Stephen Vincent
    Barn House North Street
    Rothersthorpe
    NN7 3JB Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Barn House North Street
    Rothersthorpe
    NN7 3JB Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector109731100001
    LYONS, Peter
    43 Whitefields Road
    B91 3NX Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    43 Whitefields Road
    B91 3NX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director54930900001
    MACDONALD, Bruce
    43 Kingsway Gardens
    SO53 1FF Chandlers Ford
    Hampshire
    Administrateur
    43 Kingsway Gardens
    SO53 1FF Chandlers Ford
    Hampshire
    United KingdomBritishNetwork Roll Out Director182949740001
    MACLEAN, Ian Charles
    Duart House
    Broad Hinton
    SN4 9PQ Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    Duart House
    Broad Hinton
    SN4 9PQ Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director79096180001
    MANNIX, Daniel
    4 Canterbury Close
    Aintree
    L10 8LA Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    4 Canterbury Close
    Aintree
    L10 8LA Liverpool
    Merseyside
    BritishDirector89797230001
    MARSHALL, Steven Christopher
    Latimer Lodge
    Burtons Lane
    HP8 4BS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Latimer Lodge
    Burtons Lane
    HP8 4BS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector122373680001
    NEWTON, Nigel Ernest
    Brantwood House
    Thorp, Royton
    OL2 5TH Oldham
    Lancashire
    Administrateur
    Brantwood House
    Thorp, Royton
    OL2 5TH Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector96221070002
    PERKINS, Andrew William
    45 Swinford Hollow
    Little Billing
    NN3 9HP Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    45 Swinford Hollow
    Little Billing
    NN3 9HP Northampton
    Northamptonshire
    BritishI T Manager55838180001
    PERKINS, Mark Robert
    22 Turnberry Lane
    Collingtree Park
    NN4 0PA Northampton
    Northants
    Administrateur
    22 Turnberry Lane
    Collingtree Park
    NN4 0PA Northampton
    Northants
    United KingdomBritishMarketing Director99080730001
    PERKINS, William Robert
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    3 Weavers End
    Hanslope
    MK19 7PA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishManaging Director3450600001
    RANSLEY, Brandon William
    15 Hardingstone Lane
    Hardingstone
    NN4 6DF Northampton
    Administrateur
    15 Hardingstone Lane
    Hardingstone
    NN4 6DF Northampton
    BritishSolicitor61675530001
    ROBERTS, George Powers
    15163 Alondra Lane
    Saratoga
    California
    95070
    Usa
    Administrateur
    15163 Alondra Lane
    Saratoga
    California
    95070
    Usa
    AmericanChief Executive Officer56335490002
    SHONE, Christopher John
    27 Dale Avenue
    NN8 3QT Wellingborough
    Northamptonshire
    Administrateur
    27 Dale Avenue
    NN8 3QT Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishCommercial Director3633520001

    R.T. MASTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 24 janv. 2008
    Livré le 06 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 3 morris close, park farm, north wellingborough t/no. NN142728. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 mai 2007
    Livré le 18 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 déc. 2005
    Livré le 08 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 2, 3 morris close park farm industrial estate wellingborough t/n NN142728. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 nov. 2005
    Livré le 03 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 mai 2005
    Livré le 19 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited 'Security Holder'
    Transactions
    • 19 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 29 avr. 1997
    Livré le 07 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 avr. 1997
    Livré le 07 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a 3 (formerly unit 2) morris close park farm north wellingborough northamptonshire t/no.NN142728 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 avr. 1997
    Livré le 07 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a 4 (formerly unit 3) morris close park farm north wellingborough northamptonshire and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 09 sept. 1994
    Livré le 21 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 2, chieftain business park, park farm industrial estate, wellingborough, northants and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 21 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 sept. 1992
    Livré le 25 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Legal charge over the bookdebts and the benefit of all rights thereto now and from time to time due or owing to the company.
    Personnes ayant droit
    • Maddox Factoring (UK) LTD
    Transactions
    • 25 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 20 avr. 1988
    Livré le 22 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 03 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 23 mai 1986
    Livré le 02 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 juin 1986Enregistrement d'une charge

    R.T. MASTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 déc. 2008Commencement of winding up
    16 juin 2010Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Dixon Fleming
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    practitioner
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Brian Green
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    practitioner
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0