HALIFAX MORTGAGE SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HALIFAX MORTGAGE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01981090 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HALIFAX MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HALIFAX MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour HALIFAX MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | LIQ13 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB United Kingdom à Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Trinity Road Halifax West Yorkshire HX1 2RG à 1 More London Place London SE1 2AF le 26 avr. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB | 2 pages | AD03 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lloyds Secretaries Limited en tant que secrétaire le 23 mars 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 mai 2020 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Johan Robin Charles Von Schmidt Auf Altenstadt le 21 janv. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom à Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Janet Turner en tant que directeur le 15 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Johan Robin Charles Von Schmidt Auf Altenstadt en tant qu'administrateur le 15 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Janet Turner le 10 janv. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 mai 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Bank of Scotland Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 mars 2018 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Halifax Mortgage Services (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 mars 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Nomination de Ms Janet Turner en tant qu'administrateur le 09 nov. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Stuart Dolman en tant que directeur le 09 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HALIFAX MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, Johan Robin Charles | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 254275760001 | |||||||||
| CHRISTMAS, Peter John | Secrétaire | 14 Bellever Hill GU15 2HD Camberley Surrey | British | 9647350002 | ||||||||||
| GITTINS, Paul | Secrétaire | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | 164928430001 | |||||||||||
| LOCKWOOD, Angela | Secrétaire | Lloyds Banking Group Trinity Road HX1 2RG Halifax C/O Retail Company Secretaries United Kingdom | British | 115797910001 | ||||||||||
| LODGE, Matthew Sebastian | Secrétaire | Rose Cottage Dog Lane Stainland HX4 9QF Halifax West Yorkshire | British | 32609030001 | ||||||||||
| MAYER, Sally | Secrétaire | 48 Prospect Street Shibden Heights HX3 6LG Halifax | British | 75435950002 | ||||||||||
| MCPHERSON, Donald James | Secrétaire | 17 Cross Bank BD23 6AH Skipton North Yorkshire | British | 40519810003 | ||||||||||
| SOBO, Femi | Secrétaire | 5 Carr Bridge View Cookridge LS16 7BR Leeds | British | 55778050002 | ||||||||||
| LLOYDS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom |
| 73512200003 | ||||||||||
| AMZALLAG, Robert Meyer | Administrateur | 21 Gilston Road SW10 9SJ London | French | 27978440001 | ||||||||||
| ANSLOW, Robert Michael | Administrateur | Lloyds Banking Group Trinity Road HX1 2RG Halifax C/O Retail Company Secretaries United Kingdom | British | 70435850001 | ||||||||||
| ATCHISON, Judith Clare | Administrateur | 20 Church Street Dunnington YO1 5PW York | United Kingdom | British | 41607780001 | |||||||||
| BEARDSLEY, Derrick | Administrateur | 27 Stoatley Rise GU27 1AG Haslemere Surrey | British | 27105790001 | ||||||||||
| BEDDOWS, Peter Richard | Administrateur | Austcliffe House Farm Austcliffe Road Cookley DY10 3UR Kidderminster Worcestershire | England | British | 14142380001 | |||||||||
| BRUNOT, Francois Emile | Administrateur | 62 Rue Brancion FOREIGN 75015 Paris France | French | 8265370001 | ||||||||||
| CAMERON-MOORE, David | Administrateur | Foxwood Lower Station Road Newick BN8 4HT Lewes East Sussex | British | 45562390001 | ||||||||||
| DECOURCELLE, Gerard | Administrateur | 11 Rue De La Grande Chaumiere Paris 75006 France | French | 25858810001 | ||||||||||
| DOLMAN, Mark Stuart | Administrateur | PO BOX 112 Canons Way BS99 7LB Bristol Canons House England England | United Kingdom | British | 169566090001 | |||||||||
| DUGGLEBY, Colin | Administrateur | Red Cottages Pilcot Hill RG27 8SZ Dogmersfield Hampshire | British | 69027230001 | ||||||||||
| GAUTHIER, Pierre | Administrateur | 29 Drayton Gardens SW10 3RY London | Canadian | 36865820001 | ||||||||||
| GRESHAM, Jonathan William | Administrateur | White House Farm Cold Hatton TF6 6QU Wellington Shropshire | British | 66942990001 | ||||||||||
| HUTCHINSON, Peter Graham | Administrateur | 9 Oakridge Court BD16 4TA Bingley West Yorkshire | British | 66767030001 | ||||||||||
| KINNISON, Alex | Administrateur | Blue House Bournebridge Lane RM4 1NX Lambourne End Essex | British | 35285930001 | ||||||||||
| POPE, Darren Scott | Administrateur | Chief Office Barnett Way, Gloucester, Gl4 7rl Cheltenham & Gloucester Plc United Kingdom | United Kingdom | British | 133746080001 | |||||||||
| SAGLIO, Dominique | Administrateur | 17 Rue Delambre FOREIGN Paris France | French | 27105800001 | ||||||||||
| SPELMAN, Richard | Administrateur | Folly Hall Cross Lane Kirkburton HD8 0ST Huddersfield West Yorkshire | England | British | 144006630001 | |||||||||
| STEWART, Ian Gordon | Administrateur | Lovell Park Road LS1 1NS Leeds Lovell Park United Kingdom | United Kingdom | British | 82245010005 | |||||||||
| THIREAU, Francis Rene Michel | Administrateur | 6 St Marys Gate Kensington Green W8NA London | French | 20602870001 | ||||||||||
| TURNER, Janet | Administrateur | 5th Floor 25 Gresham Street EC2V 7HM London Lloyds Banking Group United Kingdom | United Kingdom | British | 239996920001 | |||||||||
| VAN DE WEGHE, Albert David | Administrateur | 8 Parc De Bearn 92210 St Cloud Paris France | French | 9648340001 | ||||||||||
| WHITE, Paul Matthew | Administrateur | 21 Prince Street BS1 4PH Bristol Lloyds Banking Group United Kingdom | England | British | 62104870002 | |||||||||
| ZACZKIEWICZ, Stacey | Administrateur | 4 Ambleside Drive Walton WF2 6TJ Wakefield West Yorkshire | British | 51879320001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HALIFAX MORTGAGE SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Of Scotland Plc | 23 mars 2018 | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Halifax Mortgage Services (Holdings) Limited | 06 avr. 2016 | HX1 2RG Halifax Trinity Road West Yorkshire United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
HALIFAX MORTGAGE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| An agreement | Créé le 14 nov. 1989 Livré le 05 déc. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage agreement | |
Brèves mentions As continuing security by way of first fixed equitable charge (1) the loans (as deined in the agreement) (see 395 ref M16 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed charge | Créé le 09 mars 1988 Livré le 18 mars 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage portfolio participation agreement dated 4/3/88 | |
Brèves mentions All sums, rights title and interest of the company specified on the form M395. (See form per full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed charge | Créé le 09 mars 1988 Livré le 18 mars 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage portfolio participation agreement dated 4/3/88. | |
Brèves mentions All sums, rights title and interests of the company specified on the form M395. (See form per full details.). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed charge | Créé le 15 janv. 1988 Livré le 01 févr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the participation agreement dated 15.1.88 | |
Brèves mentions (See 395 and continuation sheet for full details relevant to this charge). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed | Créé le 04 déc. 1987 Livré le 21 déc. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti £500,000 | |
Brèves mentions All moneys standing to the credit of the companys deposit account no 861340 (STFDEP1) with chemical bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
HALIFAX MORTGAGE SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0