HUTHCO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUTHCO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01982875
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUTHCO LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe HUTHCO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Baris House
    Nunn Brook Road
    NG17 2HU County Estate, Huthwaite,
    Notts
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HUTHCO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BARIS UK LIMITED07 avr. 199207 avr. 1992
    BARIS (FIRE PROTECTION) LIMITED 28 janv. 198628 janv. 1986

    Quels sont les derniers comptes de HUTHCO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour HUTHCO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes établis au 31 janv. 2009

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 janv. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 janv. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 janv. 2006

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 janv. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    Comptes établis au 31 janv. 2004

    4 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    Comptes établis au 31 janv. 2003

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HUTHCO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARRY, Laura Margaret
    Abbeydale Hall
    Abbeydale Road South
    S173LJ Dore
    26
    Sheffield
    England
    Secrétaire
    Abbeydale Hall
    Abbeydale Road South
    S173LJ Dore
    26
    Sheffield
    England
    Other77297900007
    BRUCE, Anthony
    Croft House Farm 31 Bar Road North
    Beckingham
    DN10 4NN Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    Croft House Farm 31 Bar Road North
    Beckingham
    DN10 4NN Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish59900860001
    DAMMS, Terence Alan
    Bower Cottage Bland Lane
    Wadsley
    S6 4BQ Sheffield
    Administrateur
    Bower Cottage Bland Lane
    Wadsley
    S6 4BQ Sheffield
    United KingdomBritish13195770002
    HINCHCLIFFE, Howard George
    10 Eskdale Close
    S18 8PQ Dronfield
    Derbyshire
    Secrétaire
    10 Eskdale Close
    S18 8PQ Dronfield
    Derbyshire
    British111605450001
    LINFORD, Stephen Geoffrey
    Brook House School Road
    Snitterfield
    CV37 0JL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    Brook House School Road
    Snitterfield
    CV37 0JL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British15354310001
    THOMSON, William Robert
    39 Sheffield Park Avenue
    DN15 8PJ Scunthorpe
    South Humberside
    Secrétaire
    39 Sheffield Park Avenue
    DN15 8PJ Scunthorpe
    South Humberside
    British40774820001
    GAMBLE, John Russell
    5 Knowle Green
    Dore
    S17 3AP Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    5 Knowle Green
    Dore
    S17 3AP Sheffield
    South Yorkshire
    British45620710003
    HINCHCLIFFE, Howard George
    10 Eskdale Close
    S18 8PQ Dronfield
    Derbyshire
    Administrateur
    10 Eskdale Close
    S18 8PQ Dronfield
    Derbyshire
    British111605450001
    HOLMAN, Andrew Philip William
    Regents House Clevedon House
    Prince Of Wales Road
    NR27 9HR Cromer
    Norfolk
    Administrateur
    Regents House Clevedon House
    Prince Of Wales Road
    NR27 9HR Cromer
    Norfolk
    British45620670001
    LINFORD, Stephen Geoffrey
    Brook House School Road
    Snitterfield
    CV37 0JL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Brook House School Road
    Snitterfield
    CV37 0JL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British15354310001
    SMITH, Robert Ian
    The Oaks Newstead Abbey Park
    NG15 8GD Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Oaks Newstead Abbey Park
    NG15 8GD Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish54241600001
    THOMSON, William Robert
    39 Sheffield Park Avenue
    DN15 8PJ Scunthorpe
    South Humberside
    Administrateur
    39 Sheffield Park Avenue
    DN15 8PJ Scunthorpe
    South Humberside
    British40774820001

    HUTHCO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 août 1998
    Livré le 19 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 12 août 1998
    Livré le 19 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a facility agreement dated 12TH august 1998 or under the mortgage debenture and whether on any current or other account
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Trustee and Agent for Each of Itself and Close Brothers Protected Vct PLC)
    Transactions
    • 19 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 23 nov. 1994
    Livré le 30 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever limited to the sum of £300,000
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Sheffield Insulations Limited
    Transactions
    • 30 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 25 juil. 1988
    Livré le 01 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The westbarn, 3 kirkstead abbey mews, upper wortley road, thorpe hesley, south yorkshire. Title no syk 216133 and proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 1988Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 12 nov. 1987
    Livré le 18 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1987Enregistrement d'une charge
    • 03 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0