HEG (NUMBER 1) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHEG (NUMBER 1) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01984677
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HEG (NUMBER 1) LIMITED ?

    • (5146) /

    Où se situe HEG (NUMBER 1) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    822 Fountain Court
    Birchwood Boulevard Birchwood
    WA3 7QZ Warrington
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HEG (NUMBER 1) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FIRST AID UK LTD10 mars 199310 mars 1993
    STAFFORDSHIRE FIRST AID SUPPLIES LIMITED02 avr. 198602 avr. 1986
    DATECOVER LIMITED31 janv. 198631 janv. 1986

    Quels sont les derniers comptes de HEG (NUMBER 1) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour HEG (NUMBER 1) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de 17 Chesford Grange Woolston Warrington Cheshire WA1 4RQ le 27 mai 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mai 2010

    État du capital au 26 mai 2010

    • Capital: GBP 500
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Lyndon James Gaborit le 26 mai 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2009

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 juin 2008

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Certificat de changement de nom

    Company name changed first aid uk LTD\certificate issued on 25/04/08
    3 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages225

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2007

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 28 févr. 2006

    9 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2005

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HEG (NUMBER 1) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Secrétaire
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    British79348050002
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish79348050002
    GABORIT, Lyndon James
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    United Kingdom
    United KingdomAustralian133660360001
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    British54189670005
    DENOS, Kenneth
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    Secrétaire
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    American93963450001
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Secrétaire
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Australian65921870004
    PEAR, Andrew Mark
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    Secrétaire
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    British114397290001
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish54189670005
    BRUCK, Stuart
    2116 31st Street
    90266 Manhattan Beach
    California
    Administrateur
    2116 31st Street
    90266 Manhattan Beach
    California
    American57236400002
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Administrateur
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    Australian65921870004
    PEAR, Andrew Mark
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    Administrateur
    Tannen Holmes Chapel Road
    Somerford
    CW12 4QB Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish114397290001
    PEAR, Graham
    9 Fenton Close
    CW12 3TH Congleton
    Cheshire
    Administrateur
    9 Fenton Close
    CW12 3TH Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish13275040003
    PEAR, Graham
    77 Avon Drive
    CW12 3RG Congleton
    Cheshire
    Administrateur
    77 Avon Drive
    CW12 3RG Congleton
    Cheshire
    British13275040001
    PEAR, Susan Dawn
    Bramble End The Mount
    CW12 4FD Congleton
    Cheshire
    Administrateur
    Bramble End The Mount
    CW12 4FD Congleton
    Cheshire
    British100025290001
    TOMPKINS, Henry John Mark
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    Administrateur
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    EnglandBritish109723760001
    WOOD, Gordon Alexander
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    Administrateur
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    British136141810001

    HEG (NUMBER 1) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of accession and charge
    Créé le 28 juin 2004
    Livré le 01 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 06 sept. 2002
    Livré le 21 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the north east side of back lane radnor park industrial estate congleton cheshire CW12 t/n CH442637. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 29 oct. 2001
    Livré le 02 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under the financing agreement (as defined in the fixed and floating charge)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 02 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 juin 1999
    Livré le 06 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 14 silk street congleton cheshire t/no: CH360920. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 mai 1997
    Livré le 24 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge all book and other debts of the company põresent and future save for book and other debts sold by the company and purchased by the security holder under an invoice discounting agreement and not repurchased pursuant to the provisions thereof.
    Personnes ayant droit
    • New Court Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 24 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 janv. 1997
    Livré le 19 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as 12 silk st,congleton cheshire and the proceeds of sale thereof; t/no ch 331506. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 janv. 1991
    Livré le 28 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 11 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0