GILL INSULATION EASTERN LIMITED

GILL INSULATION EASTERN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGILL INSULATION EASTERN LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01985419
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GILL INSULATION EASTERN LIMITED ?

    • Autres installations en construction (43290) / Construction

    Où se situe GILL INSULATION EASTERN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Brunswick House
    1 Deighton Close
    LS22 7GZ Wetherby
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GILL INSULATION EASTERN LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 juil. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 avr. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour GILL INSULATION EASTERN LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au10 mai 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation24 mai 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au10 mai 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour GILL INSULATION EASTERN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 juil. 2023

    18 pagesAA

    legacy

    39 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 10 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2022

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2021

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2020

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 019854190011, créée le 12 mai 2020

    10 pagesMR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stuart John Moore le 20 déc. 2019

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2019

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stuart John Moore le 18 oct. 2018

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2018

    23 pagesAA

    Inscription de la charge 019854190010, créée le 26 sept. 2018

    49 pagesMR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stuart John Moore le 16 avr. 2017

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2017

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de GILL INSULATION EASTERN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BEDFORD, John Stuart
    House
    1 Deighton Close
    LS22 7GZ Wetherby
    Brunswick
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    House
    1 Deighton Close
    LS22 7GZ Wetherby
    Brunswick
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishCompany Director164625960001
    MOORE, Stuart John
    House
    1 Deighton Close
    LS22 7GZ Wetherby
    Brunswick
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    House
    1 Deighton Close
    LS22 7GZ Wetherby
    Brunswick
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director164050170013
    BILSLAND, Nicol Muir
    17 Westcliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    17 Westcliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    North Yorkshire
    British37691300001
    KIRK, Philip Anthony
    8 Ullswater Rise
    LS22 6YP Wetherby
    West Yorkshire
    Secrétaire
    8 Ullswater Rise
    LS22 6YP Wetherby
    West Yorkshire
    British35144620001
    MIDDLEMISS, Graham
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    British100701940002
    ASHMORE, Stephen, Mr.
    The Wolseley Center
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    Administrateur
    The Wolseley Center
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    EnglandBritishCompany Director232880380001
    BARDEN, Adrian
    Pearl House, 35 Pearce Avenue
    Lilliput
    BH14 8EG Poole
    Dorset
    Administrateur
    Pearl House, 35 Pearce Avenue
    Lilliput
    BH14 8EG Poole
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director66429950005
    BILTON, Edward
    Redwing
    Sidney Road Old Costessey
    NR8 5DR Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Redwing
    Sidney Road Old Costessey
    NR8 5DR Norwich
    Norfolk
    BritishCompany Director104520650001
    DREW, Allan James
    44 Broadway
    DE7 8TD Ilkeston
    Derbyshire
    Administrateur
    44 Broadway
    DE7 8TD Ilkeston
    Derbyshire
    BritishCompany Director28244070001
    DREW, Allan James
    44 Broadway
    DE7 8TD Ilkeston
    Derbyshire
    Administrateur
    44 Broadway
    DE7 8TD Ilkeston
    Derbyshire
    BritishCompany Director28244070001
    FLANAGAN, Garry Michael
    18 Sunningdale Croft
    Fixby
    HD2 2NX Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    18 Sunningdale Croft
    Fixby
    HD2 2NX Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishLogistic Director104780740001
    HADDOCK, Michael
    10 Ullswater Close
    Gedling
    NG4 4WG Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    10 Ullswater Close
    Gedling
    NG4 4WG Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director5872700001
    HADDOCK, Michael
    10 Ullswater Close
    Gedling
    NG4 4WG Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    10 Ullswater Close
    Gedling
    NG4 4WG Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director5872700001
    HARDING, Derek John
    The Wolseley Center
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    Administrateur
    The Wolseley Center
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    United KingdomBritishAccountant152377500001
    HAYES, Alan Peter
    12 Harefield
    Long Melford
    CO10 9DE Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    12 Harefield
    Long Melford
    CO10 9DE Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector72519600001
    KIRK, Philip Anthony
    8 Ullswater Rise
    LS22 6YP Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    8 Ullswater Rise
    LS22 6YP Wetherby
    West Yorkshire
    BritishCompany Director35144620001
    MCKERRACHER, Iain Douglas
    13a Kent Road
    HG1 2LE Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    13a Kent Road
    HG1 2LE Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director692370001
    MIDDLEMISS, Graham
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishSolicitor100701940002
    NEVILLE, Matthew James
    9 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    9 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director85093360003
    TILLOTSON, Ian
    The Ashes
    16 Hughes Hill
    CV35 7AS Shrewley
    Warwickshire
    Administrateur
    The Ashes
    16 Hughes Hill
    CV35 7AS Shrewley
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director109050510001
    WRIGHT, Jonathan Barry
    31 Skipper Road
    Pinewood
    IP8 3QU Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    31 Skipper Road
    Pinewood
    IP8 3QU Ipswich
    Suffolk
    BritishDirector72519470003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GILL INSULATION EASTERN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    1 Deighton Close
    LS22 7GZ Wetherby
    Brunswick House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    1 Deighton Close
    LS22 7GZ Wetherby
    Brunswick House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03455057
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GILL INSULATION EASTERN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 12 mai 2020
    Livré le 13 mai 2020
    En cours
    Brève description
    None.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 sept. 2018
    Livré le 28 sept. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 sept. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 27 oct. 2011
    Livré le 10 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 27 oct. 2011
    Livré le 10 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 27 oct. 2011
    Livré le 03 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wolseley UK Limited (Security Trustee)
    Transactions
    • 03 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 oct. 2011
    Livré le 02 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 02 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 23 juil. 1999
    Livré le 31 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities now or at any time hereafter due or owing from the company to the chargee (acting for itself and on behalf of the investors) and to the investors (as defined) or any of them pursuant to the deed of guarantee of even date
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 nov. 1997
    Livré le 29 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due owing or incurred from the company to 3I PLC for itself and as trustee for the investors (as defined in the charge) and to any of the investors pursuant to a deed of guarantee and indemnity of even date with the charge
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 29 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Créé le 20 nov. 1997
    Livré le 28 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the finance documents
    Brèves mentions
    L/H land k/a 6A and 6B tweed road clevedon t/no AV54465 l/h land k/a unit B2 knights park strood t/no K67267 l/h land k/a units 17, 18, 19 bloorsgrove estate ilkeston road nottingham t/no NT48699 for further details of property charged please refer to form 395 'the first schedule'. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 oct. 1987
    Livré le 23 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery (see doc for details).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 15 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 oct. 1986
    Livré le 20 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Stocks, shares & other securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 1986Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0