B.V.S. RENTALS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéB.V.S. RENTALS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01985727
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de B.V.S. RENTALS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe B.V.S. RENTALS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de B.V.S. RENTALS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour B.V.S. RENTALS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 janv. 2011

    5 pages4.68

    Cessation de la nomination de Matthew Jowett en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Philip Harrison en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    5 pagesAA

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    8 pagesLIQ MISC OC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 janv. 2010

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de Vt House, Grange Drive Hedge End Southampton Hampshire SO30 2DQ le 15 févr. 2010

    2 pagesAD01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Matthew Paul Jowett le 15 déc. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip James Harrison le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Richard Davies le 13 oct. 2009

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 oct. 2009

    État du capital au 27 oct. 2009

    • Capital: GBP 150,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 mars 2008

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 mars 2007

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de B.V.S. RENTALS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVIES, John Richard
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Administrateur
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritishManaging Director128289970002
    COKER, Peter John
    12 Crispin Field
    Pitstone
    LU7 9BG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Secrétaire
    12 Crispin Field
    Pitstone
    LU7 9BG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British20675290001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    GOWER, Angela
    53 Chipping Vale
    Emerson Valley
    MK4 2HT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    53 Chipping Vale
    Emerson Valley
    MK4 2HT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British31041710002
    HODGES, Andrew William
    Flat 202
    7 Garden Walk
    EC2A 3EW London
    Secrétaire
    Flat 202
    7 Garden Walk
    EC2A 3EW London
    BritishChartered Secretary77527910003
    IVES, Deborah Ann
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    British61720060001
    JONSSON, Elizabeth Irvine Reid
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British71376550001
    JOWETT, Matthew Paul
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Secrétaire
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    British205867540001
    RICHARDSON, Elaine
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    British36633090001
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary32782910002
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary32782910002
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary32782910002
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Secrétaire
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary70326980001
    COSGROVE, Peter
    36 Grove Road
    LE10 2AD Burbage
    Leicestershire
    Administrateur
    36 Grove Road
    LE10 2AD Burbage
    Leicestershire
    BritishManaging Dir33464380002
    CUNDY, Christopher John
    74 Downscroft Gardens
    Hedge End
    SO30 4RS Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    74 Downscroft Gardens
    Hedge End
    SO30 4RS Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant61210490001
    EASTER, Philip Charles
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    Administrateur
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    EnglandBritishInsurance Company Official105999210001
    GREEN, Tresham Edward David
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    Administrateur
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    BritishDirector20695790001
    HARRIS, Peter Robert
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    United KingdomBritishFinance Director50619920001
    HARRISON, Philip James
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Administrateur
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritishAccountant126366670001
    ILIC, Kosovka
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    Administrateur
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    BritishDirector20675310001
    JONSSON, Elizabeth Irvine Reid
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishAssistant Secretary71376550001
    MACHELL, Simon Christopher
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    Administrateur
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official145338560001
    PRICE, David John
    Wykham Helmdon Road
    Sulgrave
    OX17 2SQ Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Wykham Helmdon Road
    Sulgrave
    OX17 2SQ Banbury
    Oxfordshire
    BritishAccountant45828440002
    SIMPSON, Alan Keith
    Watchbury Hill Hareway Lane
    Barford
    CV35 8DD Warwick
    Administrateur
    Watchbury Hill Hareway Lane
    Barford
    CV35 8DD Warwick
    BritishManaging Director35940110003
    SMALE, Sarah Anne Margaret
    2 The Green
    Longwick
    HP27 9QY Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 The Green
    Longwick
    HP27 9QY Princes Risborough
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretarial Assistant37137790002
    SMITH, David Michael
    Woodlands
    Main Drive
    CV35 9BT Moreton Paddox
    Warwickshire
    Administrateur
    Woodlands
    Main Drive
    CV35 9BT Moreton Paddox
    Warwickshire
    BritishCompany Director47361390001
    SNOWBALL, Patrick Joseph Robert
    The Old Rectory
    Longham
    NR19 2RG East Dereham
    Norfolk
    Administrateur
    The Old Rectory
    Longham
    NR19 2RG East Dereham
    Norfolk
    BritishInsurance Company Official145338520001
    TARRANT, Simon Edward
    Redlands Farm
    Duncton
    GU28 0JY Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    Redlands Farm
    Duncton
    GU28 0JY Petworth
    West Sussex
    BritishEngineer35197570012
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Administrateur
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    AVIVA DIRECTOR SERVICES LIMITED
    St. Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Administrateur
    St. Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    60496090003

    B.V.S. RENTALS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 06 oct. 1995
    Livré le 10 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over the benfit of hire contracts.
    Personnes ayant droit
    • Hitachi Credit (UK) PLC
    Transactions
    • 10 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First fixed charge
    Créé le 08 oct. 1993
    Livré le 12 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase or lease agreements
    Brèves mentions
    (I)all sub-lease agreements.(ii)the full benefit and advantage of the moneys payable.(iii)the benefit of all guarantees and indemnities.(iv)the benefit of all insurance.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mercedes-Benz Finance Limited
    Transactions
    • 12 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Master agreement
    Créé le 06 juil. 1993
    Livré le 13 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee s
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest in the sub-hire agreements described in supplementary schedules from time to time entered into pursuant to the master agreement and in all ancillary contracts relating thereto and all (if any) the rights of the company to acquire title in the goods forming the subject matter thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royscot Leasing Limited
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Spa Leasing Limited
    • Royscot Commercial Leasing Limited
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    Transactions
    • 13 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 04 août 1987
    Livré le 11 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the and or B.V.S. watford limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 06 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 10 mars 1987
    Livré le 19 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 03 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    B.V.S. RENTALS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 janv. 2010Commencement of winding up
    04 août 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0