SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE)
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE) |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | 01985809 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE) ?
| Adresse du siège social | 90 Fenchurch Street EC3M 4ST London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE) ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE) ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Dissolution by c/order effective 31/01/2020 | 1 pages | MISC | ||||||||||
Ordonnance du tribunal Diss by c/order ef date man gaz | 24 pages | OC | ||||||||||
Gazette finale dissoute par décret | pages | GAZ2 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 33 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 37 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 32 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew John Paton en tant que directeur le 01 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 31 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juin 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2017 au 31 déc. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2016 | 35 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Patrick James Russell le 04 oct. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew John Paton le 04 oct. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Jeffrey Harris le 04 oct. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Edward Christian John Wells le 04 oct. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Philip John Hope Vaughan le 04 oct. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Brian William Darrell Richards le 04 oct. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Angela Marie Horne le 04 oct. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 juin 2016 sans liste des membres | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2015 | 29 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 juin 2015 sans liste des membres | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2014 | 29 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE) ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALPENNY, Kieran Patrick | Secrétaire | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | British | 148244790001 | ||||||
| HARRIS, Christopher Jeffrey | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | England | British | 142184450002 | |||||
| HORNE, Angela Marie | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | England | British | 155506440001 | |||||
| RICHARDS, Brian William Darrell | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 21547340002 | |||||
| RUSSELL, Patrick James | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 13206950007 | |||||
| VAUGHAN, Philip John Hope | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 38959650003 | |||||
| WELLS, Edward Christian John | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | England | British | 65568680002 | |||||
| JARRETT, Ian Richard | Secrétaire | 2 Garrard Road SM7 2ER Banstead Surrey | British | 3243820003 | ||||||
| BARKER, Christopher Shelley | Administrateur | Lion Cottage Firbeck S81 8JT Worksop Nottinghamshire | British | 1427210001 | ||||||
| BATTEN, David Henry Cary | Administrateur | The Keepers Cottage Ryme Intrinseca DT9 6JP Sherborne Dorset | England | British | 13365670001 | |||||
| BROOKS, Simon David | Administrateur | 1 Hardwick Place Woburn Sands MK17 8QQ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 98377180001 | ||||||
| CHALLANDS, Richard | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 45075930001 | |||||
| CROSSLEY, Peter Mortimer | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 83608220004 | |||||
| DIXON, Christopher John Arnold | Administrateur | Forge Cottage Hurst Green RH8 9BS Oxted Surrey | British | 2504840001 | ||||||
| GOSLING, John Arthur | Administrateur | 15 Broadwalk SK9 5PJ Wilmslow Cheshire | British | 44513610001 | ||||||
| GREEN, Christopher James | Administrateur | 48 High Street HP16 0AU Great Missenden Buckinghamshire | British | 5057020002 | ||||||
| HAYES, Derek | Administrateur | The Old Rectory Brook Hill Little Waltham CM3 3LJ Chelmsford Essex | England | British | 26790660002 | |||||
| HUNT, David James Fletcher, Lord Hunt Of Wirral | Administrateur | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | England | British | 195584400004 | |||||
| LANCASTER, David Bernard | Administrateur | Shalden Park Farm Shalden GV34 4DS Alton Hampshire | United Kingdom | British | 263055100002 | |||||
| MACCABE, Michael Murray | Administrateur | 10 Elm Place SW7 3QJ London | British | 2846830001 | ||||||
| MALTHOUSE, Richard Harold | Administrateur | Fair Acre Ockham Road North KT24 6NT East Horsley Surrey | British | 2430250001 | ||||||
| MCLOUGHLIN, Kevin | Administrateur | 98 Riverdale Road S10 3FD Sheffield South Yorkshire | British | 39126020001 | ||||||
| MOSELEY, Richard John | Administrateur | Monnow Mill House Osbaston Road NP5 4AX Monmouth Gwent | United Kingdom | British | 142446580001 | |||||
| ORCHARD, John Charles Johnson | Administrateur | Honington Glebe Honington CV36 5AA Shipston On Stour Warwickshire | British | 13206930001 | ||||||
| PARKER, Roger John | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | England | British | 73555880002 | |||||
| PATON, Andrew John | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 133448930002 | |||||
| PAYTON, Michael Andrew Hartland | Administrateur | 30 Bisham Gardens Highgate N6 6DD London | United Kingdom | British | 4554960001 | |||||
| PERRIN, Christopher Courtenay | Administrateur | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 146776090001 | |||||
| ROSENHEIM, John Frank | Administrateur | 32 Maida Avenue Little Venice W2 1ST London | British | 106443500001 | ||||||
| RUSSELL, David Wallace | Administrateur | Montgomery House Montgomery Road PO9 2RH Havant Hampshire | England | British | 62852230001 | |||||
| SIMSON, Peregrine Anthony Litton | Administrateur | Corn Hall Sudbury Road CO8 5JP Bures St Mary Suffolk | British | 47409820001 | ||||||
| TAPSFIELD, Richard Harold | Administrateur | Greenwood Gate Ewehurst Lane Speldhurst TN3 0JX Tunbridge Wells Kent | England | British | 51194340001 | |||||
| TAPSFIELD, Richard Harold | Administrateur | Greenwood Gate Ewehurst Lane Speldhurst TN3 0JX Tunbridge Wells Kent | England | British | 51194340001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE) ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 20 juin 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0