CARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED

CARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01986549
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BIDDLE LIMITED09 mai 200009 mai 2000
    TILEHOUSE GROUP PLC31 juil. 198731 juil. 1987
    AIMBERRY LIMITED06 févr. 198606 févr. 1986

    Quels sont les derniers comptes de CARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au17 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation01 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au17 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour CARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Inscription de la charge 019865490018, créée le 03 déc. 2024

    99 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    26 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Neil Michael Pragg en tant qu'administrateur le 10 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan Paul Moore en tant que directeur le 06 août 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jonathan Paul Moore en tant que secrétaire le 06 août 2023

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 019865490015, créée le 26 mai 2023

    95 pagesMR01

    Inscription de la charge 019865490016, créée le 26 mai 2023

    25 pagesMR01

    Inscription de la charge 019865490017, créée le 26 mai 2023

    20 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    26 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Jonathan Moore le 29 mars 2023

    1 pagesCH03

    Nomination de Mr Jonathan Moore en tant que secrétaire le 29 mars 2023

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Andrew Smith en tant que secrétaire le 29 mars 2023

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de David Lewis Carver en tant que directeur le 01 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Jonathan Paul Moore en tant qu'administrateur le 28 févr. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Andrew Smith en tant que secrétaire le 06 déc. 2021

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Neil Joseph Davies en tant que directeur le 06 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    28 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Smith en tant que secrétaire le 04 oct. 2021

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Neil Joseph Davies en tant qu'administrateur le 04 oct. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Andrew Smith en tant que secrétaire le 07 sept. 2021

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Stuart Lee Fyfe en tant que directeur le 07 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KILLEEN, Aidan Dominic
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishGroup Chief Executive169374120001
    PRAGG, Neil Michael
    Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    15
    England
    Administrateur
    Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    15
    England
    United KingdomBritishGroup Finance Director83699180002
    BIDDLE, Anthony Garry
    112 Barton Road
    CB3 9LH Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    112 Barton Road
    CB3 9LH Cambridge
    Cambridgeshire
    British16049460001
    FYFE, Stuart Lee
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Secrétaire
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    194877720001
    JONES, David Antony
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Secrétaire
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    BritishDirector Company Secretary44452300001
    MOORE, Jonathan Paul
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Secrétaire
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    307292350001
    SMITH, Andrew
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Secrétaire
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    290304210001
    SMITH, Andrew
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Secrétaire
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    287032910001
    BALMER, Henry Richard
    Devon House 66 Northumberland Road
    CV32 6HB Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Devon House 66 Northumberland Road
    CV32 6HB Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishCompany Director1637840001
    BIDDLE, Anthony Garry
    112 Barton Road
    CB3 9LH Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    112 Barton Road
    CB3 9LH Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishCompany Director16049460001
    CARVER, David Lewis
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishDirector15922050001
    COOPER, Christopher Norman
    High House
    Longsleddale
    LA8 9BB Kendal
    Cumbria
    Administrateur
    High House
    Longsleddale
    LA8 9BB Kendal
    Cumbria
    United KingdomBritishDirector2882240001
    DAVIES, Neil Joseph
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    United KingdomBritishGroup Financial Director288043660001
    FYFE, Stuart Lee
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishGroup Finance Director301272730001
    JONES, David Antony
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector Company Secretary44452300001
    KWAK, Peter William
    2 The Spinney
    Mancetter
    CV9 1RS Atherstone
    Warwickshire
    Administrateur
    2 The Spinney
    Mancetter
    CV9 1RS Atherstone
    Warwickshire
    BritishCompany Director1441060001
    LANDOLT, Richard Binham
    Harp House
    108 Henwood Green Road
    TN2 4LN Pembury
    Kent
    Administrateur
    Harp House
    108 Henwood Green Road
    TN2 4LN Pembury
    Kent
    BritishCompany Director47024490001
    LIGTENBERG, Petrus Josephus Joannes Hubertus
    Slinge 23
    FOREIGN 9204 Kk Drachten
    Netherlands
    Administrateur
    Slinge 23
    FOREIGN 9204 Kk Drachten
    Netherlands
    DutchCompany Director41698280001
    MOORE, Jonathan Paul
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishGroup Finance Director221845950001
    MORRISON, Douglas
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    15 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishDirector43176540001
    VAN ROOIJ, Marcus Maria
    Boymansweg 1
    1064 Wr
    Amersterdam
    Netherlands
    Administrateur
    Boymansweg 1
    1064 Wr
    Amersterdam
    Netherlands
    DutchDirector78776870001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    15
    England
    17 juin 2017
    Northgate
    Aldridge
    WS9 8QD Walsall
    15
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00509127
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CARVER CLIMATE SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 déc. 2024
    Livré le 06 déc. 2024
    En cours
    Brève description
    The freehold property known as land on the north side of st marys road, nuneaton with title number WK221510. For more details please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC (As Security Agent and Security Trustee)
    Transactions
    • 06 déc. 2024Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 mai 2023
    Livré le 08 juin 2023
    En cours
    Brève description
    All present and future securities held by carver climate systems limited in carver climate holdings inc. (The "securities") (more particularly described in the schedule to the instrument) together with the proceeds derived from dealing with these securities. For more details please refer to the instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 mai 2023
    Livré le 08 juin 2023
    En cours
    Brève description
    The inter-company debt and the subordinated security in each case as defined in the collateral assignment registered by this form MR01 (the "collateral assignment"). For more details please refer to the collateral assignment.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 mai 2023
    Livré le 08 juin 2023
    En cours
    Brève description
    The freehold property known as land on the north side of st marys road, nuneaton with title number WK221510. For further details of property charged please see the debenture registered by this form MR01 (the “debenture”). The specified shares, specified bank balances, all current and future properties, equipment, securities, book debts and intellectual property owned by the company, in each case as defined in the debenture. For more details please refer to the debenture.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 31 août 2018
    Livré le 05 sept. 2018
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transactions
    • 05 sept. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 31 août 2018
    Livré le 05 sept. 2018
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transactions
    • 05 sept. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 31 août 2018
    Livré le 05 sept. 2018
    En cours
    Brève description
    Land on the north side of st mary's road, nuneaton title number: WK221510; 15 northgate, aldridge, walsall, WS9 8QD title number: WM984304 - for more details, please refer to the instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transactions
    • 05 sept. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 nov. 2016
    Livré le 16 déc. 2016
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 nov. 2016
    Livré le 16 déc. 2016
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 nov. 2016
    Livré le 02 déc. 2016
    En cours
    Brève description
    Pursuant to clause 3.1.2(v) of the instrument, the company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the instrument). For further details, please refer to the instrument. Pursuant to clause 3.1.1 and clause 3.1.2(I), the company charged by way of first legal mortgage and first fixed charge all its real property (although no further details are specified in the instrument). For further details, please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    Guarantee & debenture
    Créé le 06 janv. 2012
    Livré le 11 janv. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies and limited liability partnerships named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 janv. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Ssecurity agreement
    Créé le 19 déc. 2011
    Livré le 30 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land on the north side of st marys road nuneaton t/no WK221510 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • David Antony Jones as Trustee of the Carver PLC Pension Scheme, David Lewis Carver as Trustee of the Carver PLC Pension Scheme, Kevin Neil Cowie as Trustee of the Carver PLC Pension Scheme, Jennifer Jayne Lewis as Trustee of the Biddle Pension and Life Assurance Plan, Martin John Cook as Trustee of the Biddle Pension and Life Assurance Plan and David Antony Jones as Trustee of the Biddle Pension and Life Assurance Plan
    Transactions
    • 30 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 19 déc. 2011
    Livré le 23 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Adelphi Funding Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 24 févr. 2004
    Livré le 10 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 avr. 1999
    Livré le 12 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    St. Mary's road nuneaton warwickshire t/n WK221510.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 1999
    Livré le 12 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 déc. 1990
    Livré le 07 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north side of st. Mary's road, nuneaton, warwickshire, title no wk 221510.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 12 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 15 août 1986
    Livré le 21 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over the company's f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof including fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 1986Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0