CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01994696 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED ?
| Adresse du siège social | 2 Minster Court Mincing Lane EC3R 7BB London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 16 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 30 juin 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 16 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées de l'administrateur James Frederick East le 09 févr. 2026 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 32 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Inscription de la charge 019946960016, créée le 11 avr. 2025 | 84 pages | MR01 | ||||||||||||||
Inscription de la charge 019946960017, créée le 11 avr. 2025 | 14 pages | MR01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Olyffe Yerbury en tant que directeur le 31 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 32 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de James Frederick East en tant qu'administrateur le 01 mai 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Chantel Athlene Garfield en tant que directeur le 01 mai 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Richard Olyffe Yerbury en tant qu'administrateur le 31 déc. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Damian Ely en tant que directeur le 31 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Andrew Frank Rice en tant qu'administrateur le 31 déc. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 30 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Chantel Athlene Garfield le 09 oct. 2023 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des détails de The Richards Hogg Lindley Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 oct. 2023 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Minster Building 21 Mincing Lane London EC3R 7AG England à 2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7BB le 09 oct. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Charles Taylor Administration Services Limited le 09 oct. 2023 | 1 pages | CH04 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 31 pages | AA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 22 juil. 2021
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 31 pages | AA | ||||||||||||||
Inscription de la charge 019946960015, créée le 19 oct. 2021 | 14 pages | MR01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES TAYLOR ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Secrétaire | Minster Court Mincing Lane EC3R 7BB London 2 United Kingdom |
| 157558200001 | ||||||||||
| EAST, James Frederick | Administrateur | Minster Court Mincing Lane EC3R 7BB London 2 United Kingdom | England | British | 322662720002 | |||||||||
| RICE, Andrew Frank | Administrateur | Minster Court Mincing Lane EC3R 7BB London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 255843450001 | |||||||||
| BERRY, John Gordon | Secrétaire | Flat 20b 20 The Barons TW1 2AP Twickenham Middlesex | British | 37142130001 | ||||||||||
| BIRD, Robert Arthur | Secrétaire | 14 Coulsdon Rise CR5 2SA Coulsdon Surrey | British | 23723280001 | ||||||||||
| BRICKNELL, Sarah Louise | Secrétaire | 105b Tranmere Road Earlsfield SW18 3QP London | British | 45306460001 | ||||||||||
| KEANE, Ivan John | Secrétaire | 19 Belsize Road NW6 4RX London | British | 65092840002 | ||||||||||
| RAYNER, John Henry | Secrétaire | Emperor House 35 Vine Street EC3N 2RH London | British | 1564830001 | ||||||||||
| ANDERSEN, Julian Nils | Administrateur | 14 Giles Coppice Dulwich SE19 1XF London | British | 19161380001 | ||||||||||
| BYCROFT, Geoffrey | Administrateur | The Grange Church Lane London Thorpe NG31 9RX Grantham Lincolnshire | British | 16664220001 | ||||||||||
| CARPENTER, Nigel David | Administrateur | 97 Wimbledon Park Road Southfields SW18 5TT London | United Kingdom | British | 30847470002 | |||||||||
| CLARKE, Arthur Kenneth | Administrateur | 17 Shenfield Crescent CM15 8BN Brentwood Essex | United Kingdom | British | 78778390001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Arthur | Administrateur | 12-13 Essex Street WC2R 3AA London Standard House | United Kingdom | British | 30911760001 | |||||||||
| CLARKE, Stephen Andrew | Administrateur | 6 Esmond Road Chiswick W4 1JQ London | England | British | 42862450003 | |||||||||
| COLE, Douglas Andrew | Administrateur | 7 Lake Road TN4 8XT Tunbridge Wells Kent | British | 38310860002 | ||||||||||
| DAVIES, Mark Lloyd | Administrateur | 21 Mincing Lane EC3R 7AG London The Minster Building England | England | British | 200158690001 | |||||||||
| DEAN, Michael Charles | Administrateur | Everards Sewards End CB10 2LF Saffron Walden Essex | England | British | 59268590001 | |||||||||
| DHIR, Kapil | Administrateur | 12-13 Essex Street WC2R 3AA London Standard House | United Kingdom | British | 178748160001 | |||||||||
| ELHARMELL, Mohammed | Administrateur | 118 Marshall Road Rainham ME8 0AN Gillingham Kent | British | 88321530001 | ||||||||||
| ELY, Thomas Damian | Administrateur | Minster Court Mincing Lane EC3R 7BB London 2 United Kingdom | England | British | 59348270003 | |||||||||
| FITZSIMONS, George William | Administrateur | 12-13 Essex Street WC2R 3AA London Standard House | United Kingdom | British | 105693390001 | |||||||||
| FITZSIMONS, George William | Administrateur | 30 Barrowfield Cuckfield RH17 5ER Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | 105693390001 | |||||||||
| GARFIELD, Chantel Athlene | Administrateur | Minster Court Mincing Lane EC3R 7BB London 2 United Kingdom | England | British | 277038300001 | |||||||||
| HEBDITCH, Charles Silvius | Administrateur | The Old Rectory Fringford OX6 9DX Bicester Oxfordshire | England | British | 47877070001 | |||||||||
| HOPKINS, William Brodnax | Administrateur | 19807 Maple Close Houston Texas 77094 | Us | 61144050003 | ||||||||||
| JACKSON, Andrew Paul | Administrateur | 20 Lowdells Close RH19 2HB East Grinstead West Sussex | British | 57431650002 | ||||||||||
| KEANE, Ivan John | Administrateur | 21 Mincing Lane EC3R 7AG London The Minster Building England | England | British | 65092840002 | |||||||||
| KEOGH, Mark William | Administrateur | 21 Mincing Lane EC3R 7AG London The Minster Building England | England | Irish | 62140690001 | |||||||||
| LYNGBERG, Bent Soren | Administrateur | Holck Winterfedts Alle 7 Dk-2900 Helleryp Denmark | Danish | 40555620001 | ||||||||||
| MACCOLL, Michael Dennis | Administrateur | Bullington End Farm Bullington End MK19 7BQ Buckinghamshire | British | 88896970002 | ||||||||||
| MADELEY, Charles Raymond | Administrateur | 1535 Oxford Houston Texas Tx77008 Usa | American | 81391420001 | ||||||||||
| MAROCK, David Gideon | Administrateur | 12-13 Essex Street WC2R 3AA London Standard House | United Kingdom | British | 136189130001 | |||||||||
| MCKAY, John Stewart | Administrateur | Headley Common Road KT18 6NR Headley The White House Surrey | England | British | 138496700001 | |||||||||
| MCMAHON, Joseph | Administrateur | Willows Guildford Lodge Drive KT24 6RJ East Horsley Surrey | England | British | 186218380001 | |||||||||
| MCMAHON, Joseph | Administrateur | Willows Guildford Lodge Drive KT24 6RJ East Horsley Surrey | England | British | 186218380001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Richards Hogg Lindley Group Limited | 06 avr. 2016 | Minster Court Mincing Lane EC3R 7BB London 2 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0