BAHIA PHARMACY LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBAHIA PHARMACY LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01995145
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BAHIA PHARMACY LTD ?

    • Pharmacie en officine (47730) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe BAHIA PHARMACY LTD ?

    Adresse du siège social
    32 Demontfort Street
    LE1 7GD Leicester
    Leicestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BAHIA PHARMACY LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BAHIA & BAWRIE PHARMACY LTD06 janv. 199906 janv. 1999
    FENSHIRE LIMITED04 mars 198604 mars 1986

    Quels sont les derniers comptes de BAHIA PHARMACY LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour BAHIA PHARMACY LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 28 févr. 2017

    7 pagesAA

    Satisfaction de la charge 019951450013 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2016

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juin 2016

    État du capital au 24 juin 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Inscription de la charge 019951450013, créée le 10 mai 2016

    40 pagesMR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2015

    6 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 août 2015

    État du capital au 11 août 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 9 Church Lane Knighton Leicester LE2 3WG à 32 Demontfort Street Leicester Leicestershire LE1 7GD le 11 août 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 juin 2014

    État du capital au 12 juin 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Saroj Bahia en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Amarbir Johal en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01

    Nomination de Amarbir Johal en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Satisfaction de la charge 019951450011 en totalité

    4 pagesMR04

    Nomination de Mr Amarbir Singh Johal en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Inscription de la charge 019951450012

    33 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Parminder Bahia en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Parminder Bahia en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BAHIA PHARMACY LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JOHAL, Amarbir
    LE1 7GD Leicester
    32 Demontfort Street
    Leicestershire
    England
    Secrétaire
    LE1 7GD Leicester
    32 Demontfort Street
    Leicestershire
    England
    British186951330001
    JOHAL, Amarbir Singh
    Church Lane
    Knighton
    LE2 3WG Leicester
    9
    England
    Administrateur
    Church Lane
    Knighton
    LE2 3WG Leicester
    9
    England
    United KingdomBritishNone105705530001
    BAHIA, Parminder Pal Singh
    Sefton Drive
    NG3 5ER Nottingham
    18
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Sefton Drive
    NG3 5ER Nottingham
    18
    Nottinghamshire
    British14526160002
    BAHIA, Parminder Pal Singh
    Sefton Drive
    NG3 5ER Nottingham
    18
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Sefton Drive
    NG3 5ER Nottingham
    18
    Nottinghamshire
    EnglandBritishPharmacist14526160002
    BAHIA, Saroj
    Sefton Drive
    NG3 5ER Nottingham
    18
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Sefton Drive
    NG3 5ER Nottingham
    18
    Nottinghamshire
    EnglandBritishSolicitor87134580002
    BAWRIE, Suresh Kumar
    104 Ranelagh Grove
    Wollaton
    NG8 1HU Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    104 Ranelagh Grove
    Wollaton
    NG8 1HU Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishPharmacist14526170001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BAHIA PHARMACY LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Saffron Apothecaries (Leicester) Limited
    LE1 7GD Leicester
    32 Demontfort Street
    Leicestershire
    England
    01 juil. 2016
    LE1 7GD Leicester
    32 Demontfort Street
    Leicestershire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies Act
    Numéro d'enregistrement01290875
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    BAHIA PHARMACY LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 mai 2016
    Livré le 11 mai 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    None.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 11 mai 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 juil. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 févr. 2014
    Livré le 21 mars 2014
    En cours
    Brève description
    F/H l/h bahia pharmacy situated at 1 oak court wood street mansfield nottinghamshire t/no NT176996. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 21 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 mai 2013
    Livré le 31 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 31 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 25 juin 2010
    Livré le 29 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 29 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 30 janv. 2004
    Livré le 05 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property at 1 wood street mansfield nottingham t/n NT176996. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 2003
    Livré le 11 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage 1 wood street mansfield nottingham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 31 janv. 2003
    Livré le 04 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 mai 1991
    Livré le 16 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 16 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 04 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 mai 1991
    Livré le 16 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all stocks bonds and securities in blandford chemists including all dividends interest or other distributions (see form 395 relevant to this charge).
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 16 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 04 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 déc. 1989
    Livré le 07 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 07 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juin 1989
    Livré le 19 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All stocks shares bonds and securities owned in beech chemists limited including dividends interest or other distributions (see form 395 relevant to this charge).
    Personnes ayant droit
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transactions
    • 19 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 04 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juin 1989
    Livré le 19 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All stocks shares bonds and securities owned in beech chemists limited including dividends interest or other distributions (see form 395 relevant to this charge).
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 19 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 04 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 juin 1989
    Livré le 04 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transactions
    • 04 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 04 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0