KEEPMOAT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKEEPMOAT LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01998780
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KEEPMOAT LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe KEEPMOAT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Keepmoat The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    South Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KEEPMOAT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KEEPMOAT PLC26 juin 199726 juin 1997
    KEEPMOAT HOLDINGS PLC29 juil. 198629 juil. 1986
    FACTCRAFT LIMITED12 mars 198612 mars 1986

    Quels sont les derniers comptes de KEEPMOAT LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 oct. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 juil. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour KEEPMOAT LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au23 mai 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation06 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au23 mai 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour KEEPMOAT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Mark John Dilley en tant qu'administrateur le 30 sept. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Richard Priest en tant que directeur le 30 sept. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 23 mai 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 oct. 2023

    109 pagesAA

    Cessation de la nomination de Mark Richard Priest en tant que secrétaire le 31 juil. 2023

    1 pagesTM02

    Nomination de Louise Marie Casey en tant que secrétaire le 31 juil. 2023

    2 pagesAP03

    Comptes consolidés établis au 31 oct. 2022

    88 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Lyn Michelle Charters en tant que secrétaire le 26 août 2022

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Mark Richard Priest en tant que secrétaire le 30 août 2022

    2 pagesAP03

    Comptes consolidés établis au 31 oct. 2021

    86 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 019987800016, créée le 31 janv. 2022

    11 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 019987800014 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 019987800015 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes consolidés établis au 31 oct. 2020

    87 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 mai 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 oct. 2019

    79 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 17 juin 2020

    • Capital: GBP 313,842
    3 pagesSH01

    Inscription de la charge 019987800015, créée le 12 juin 2020

    21 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 23 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 23 mai 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de James Michael Douglas Thomson en tant que directeur le 08 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 31 oct. 2018

    79 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 11 déc. 2018

    • Capital: GBP 313,841
    4 pagesSH01

    Qui sont les dirigeants de KEEPMOAT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CASEY, Louise Marie
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Secrétaire
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    311919040001
    BEALE, Timothy Mark
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director244762250001
    DILLEY, Mark John
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    EnglandBritishAccountant235466280001
    BLUNT, David
    159 Windsor Road
    Carlton In Lindrick
    S81 9DH Worksop
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    159 Windsor Road
    Carlton In Lindrick
    S81 9DH Worksop
    Nottinghamshire
    British46808670001
    BLUNT, David
    5 Milton Court
    Swinton
    S64 8RE Mexborough
    S Yorkshire
    Secrétaire
    5 Milton Court
    Swinton
    S64 8RE Mexborough
    S Yorkshire
    British14445490002
    BRANDON, Richard Harold John
    3 Highfield Villas
    Doncaster Road Costhorpe
    S81 9QX Worksop
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    3 Highfield Villas
    Doncaster Road Costhorpe
    S81 9QX Worksop
    Nottinghamshire
    British34584790002
    CHARTERS, Lyn Michelle
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Secrétaire
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    230727040001
    PRIEST, Mark Richard
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Secrétaire
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    299954500001
    ALLISON, Thomas Eardley
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    Administrateur
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director1037730004
    ASH, Nicholas Peter
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director176711910001
    BLUNT, David
    Lea Brook
    Wentworth
    S62 7SH Rotherham
    Brook Cottage
    S Yorks
    Administrateur
    Lea Brook
    Wentworth
    S62 7SH Rotherham
    Brook Cottage
    S Yorks
    EnglandBritishCompany Director14445490003
    BOVIS, Christopher
    50 Woodhall Way
    Molescroft
    HU17 7BJ Beverley
    North Humberside
    Administrateur
    50 Woodhall Way
    Molescroft
    HU17 7BJ Beverley
    North Humberside
    EnglandGreekAcademic49090430001
    BRAMALL, Terence George
    62 York Place
    HG1 5RH Harrogate
    Administrateur
    62 York Place
    HG1 5RH Harrogate
    United KingdomBritishCompany Director21742280005
    BRIDGES, David
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector171856100001
    COWIE, David Eric
    Fountainbridge
    Level 1 Ci
    EH3 9PE Edinburgh
    150
    United Kingdom
    Administrateur
    Fountainbridge
    Level 1 Ci
    EH3 9PE Edinburgh
    150
    United Kingdom
    ScotlandBritishCompany Director116639720002
    CUTLER, Mark Lloyd
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector185822570001
    HARDING, David John
    Clouds Hill 24 Thorburn Road
    NN3 3DA Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Clouds Hill 24 Thorburn Road
    NN3 3DA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director95649420001
    HICKLING, Allen
    32 Wharfedale Road
    Pogmoor
    S75 2LJ Barnsley
    South Yorkshire
    Administrateur
    32 Wharfedale Road
    Pogmoor
    S75 2LJ Barnsley
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director30855380001
    HINDLEY, Peter
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director120534750001
    JARUGA, Eugien Mieczyslaw
    The Hayloft 1 Greenland Court
    Farrer Lane Oulton
    LS26 8GB Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Hayloft 1 Greenland Court
    Farrer Lane Oulton
    LS26 8GB Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director64776110002
    PRIEST, Mark Richard
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director174767820001
    SHERIDAN, David
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector171856300001
    SUTCLIFFE, Ian Calvert
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director112534590002
    TAYLOR, William Roland
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director134011320001
    THIRWALL, John Derek
    380 Herringthorpe Valley Road
    Whiston
    S60 4LA Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    380 Herringthorpe Valley Road
    Whiston
    S60 4LA Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director108804460002
    THOMSON, James Michael Douglas
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    Administrateur
    The Waterfront
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    Keepmoat
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector71716020001
    WARD, Roger Howard
    Ash Holt 83 Doncaster Road
    Tickhill
    DN11 9JB Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    Ash Holt 83 Doncaster Road
    Tickhill
    DN11 9JB Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director12482710001
    WATSON, Richard
    Brook House Lindrick Tickhill
    DN11 9RD Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    Brook House Lindrick Tickhill
    DN11 9RD Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director5644880001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KEEPMOAT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    The Waterfront
    England
    06 avr. 2016
    Lakeside Boulevard
    DN4 5PL Doncaster
    The Waterfront
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUk
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06339103
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    KEEPMOAT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 31 janv. 2022
    Livré le 01 févr. 2022
    En cours
    Brève description
    None.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited as Security Agent
    Transactions
    • 01 févr. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2020
    Livré le 16 juin 2020
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 16 juin 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 11 déc. 2018
    Livré le 14 déc. 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Fixed charge covers intellectual property and real property which is noted in part 5 of the schedule and includes properties such as thurnscoe phase 2 with title number SYK536243. For further details please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 juin 2017
    Livré le 09 juin 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The leasehold land known as land at campsall road, askern, doncaster shown edged red on the plan attached to the legal charge and assignment (the "plan") (excluding the area shaded blue on the plan) and registered at hm land registry as part of title number SYK627293.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Homes and Communities Agency
    Transactions
    • 09 juin 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 nov. 2014
    Acquis le 27 mars 2017
    Livré le 08 mai 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    This MR02 has been submitted in connection with keepmoat limited's acquisition of the following companies listed in part b (column 3) of the security accession deed: warmer homes limited and goldhall electrical limited. None of these companies have property listed in schedule 2 of the security accession deed.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent for the Secured Parties.
    Transactions
    • 08 mai 2017Enregistrement d'une acquisition (MR02)
    • 13 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 nov. 2014
    Acquis le 27 mars 2017
    Livré le 05 avr. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    This MR02 has been submitted in connection with keepmoat limited's acquisition of the following companies listed in part b (column 3) of the security accession deed: apollo education limited, apollo housing limited, apollo response limited, apollo maintain limited, own space limited. None of these companies have property listed in schedule 2 of the security accession deed.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent for the Secured Parties.
    Transactions
    • 05 avr. 2017Enregistrement d'une acquisition (MR02)
    • 13 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 nov. 2014
    Livré le 08 déc. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 08 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 oct. 2012
    Livré le 02 nov. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Agent)
    Transactions
    • 02 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 mars 2012
    Livré le 04 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC, as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transactions
    • 04 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 04 déc. 2008
    Livré le 06 déc. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the companies to the chargee and/or the jsl note holders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land on the north east side of lakeside boulevard doncaster south yorkshire t/no. SYK512706 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Jsl Note Holders (The Investor Secuirty Trustee)
    Transactions
    • 06 déc. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 04 déc. 2008
    Livré le 06 déc. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mr David Blunt
    Transactions
    • 06 déc. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 16 août 2007
    Livré le 04 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the senior secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (For details of property charge please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 04 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 16 août 2007
    Livré le 04 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property being land on the north east side of lakeside boulevard t/no SYK512706 and fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thejsl Note Holders (The Investor Security Trustee)
    Transactions
    • 04 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite debenture
    Créé le 16 août 2007
    Livré le 21 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property being land on the north east side of lakeside boulevard t/no SYK512706 and fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mr David Blunt (Security Trustee)
    Transactions
    • 21 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 09 janv. 1989
    Livré le 17 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from frank haslam milan & co limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H lands hereditaments & premises being 1 regent terrace south parade doncaster in the county of south yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 05 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 17 oct. 1986
    Livré le 22 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating change on the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 23 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0