SILICON GRAPHICS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SILICON GRAPHICS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02002315 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SILICON GRAPHICS LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Hewlett-Packard Limited Cain Road Amen Corner RG12 1HN Bracknell England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SILICON GRAPHICS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 24 juin 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour SILICON GRAPHICS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 9 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 oct. 2019 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | LIQ01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Marc Edward Waters en tant que directeur le 30 sept. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 21 sept. 2018
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2018 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2017 au 31 déc. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 16 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 16 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 200 Berkshire Place Wharfedale Road Winnersh Wokingham Berkshire RG41 5rd à C/O Hewlett-Packard Limited Cain Road Amen Corner Bracknell RG12 1HN le 20 déc. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Philippa Anne Oram en tant qu'administrateur le 31 oct. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Coombs en tant que directeur le 31 oct. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Tara Dawn Trower en tant que secrétaire le 22 mai 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SILICON GRAPHICS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROWER, Tara Dawn | Secrétaire | Cain Road RG12 1HN Bracknell Amen Corner Berkshire England | 231970710001 | |||||||
| ORAM, Philippa Anne | Administrateur | Cain Road Amen Corner RG12 1HN Bracknell C/O Hewlett-Packard Limited England | United Kingdom | British | 216446590001 | |||||
| DANIELS, Tanya Collette | Secrétaire | Cranbourne House 1 Manor Copse Knights Enham SP10 4EF Andover Hampshire | British | 123228650001 | ||||||
| JACOBS, Nicholas Lewis | Secrétaire | Yew Tree Cottage Wolverton Common RG26 5RY Tadley Hampshire | British | 77634340001 | ||||||
| KLINGER, Paul | Secrétaire | Les Godaines George Road St Peter Port GY1 1BD Guernsey Channel Islands | British | 106221780001 | ||||||
| LAUB, Sam Edward | Secrétaire | 18 Avenue Louis Casai Geneva 1209 Switzerland | American | 29569960001 | ||||||
| LUFF, Peter Brian | Secrétaire | Berkshire Place Wharfedale Road Winnersh RG41 5RD Wokingham 200 Berkshire United Kingdom | 151491460001 | |||||||
| MITCHELL, William | Secrétaire | Berkshire Place Wharfedale Road Winnersh RG41 5RD Wokingham 200 Berkshire United Kingdom | 160818370001 | |||||||
| NUVOLETTA, Carlo | Secrétaire | 19 Moorlands Close GU51 3PL Fleet Hampshire | Italian | 112734890001 | ||||||
| WINKHAUS, Dirk | Secrétaire | 266 Elgin Avenue W9 1JR London | German | 123447560001 | ||||||
| ABRAHAMSEN, Jan | Administrateur | Berkshire Place Wharfedale Road Winnersh RG41 5RD Wokingham 200 Berkshire | England | Norwegian | 123447460001 | |||||
| BISHOP, Robert | Administrateur | 18 Avenue Louis Casai Geneva 1209 Switzerland | Australian | 18770790001 | ||||||
| BRYCK, Cathryn | Administrateur | 1972 Goodwin Avenue Redwood City California 94061 America | American | 69669000001 | ||||||
| BUTCHART, Timothy William Russell | Administrateur | 5 Hogarth Way TW12 2EL Hampton Middlesex | United Kingdom | British | 75188070001 | |||||
| CAKEBREAD, Steve Mark | Administrateur | 1075 Greenfield Road St Helena Ca California 94574 FOREIGN Usa | American | 48872500001 | ||||||
| CHEHLAOUI, Samer | Administrateur | 31 Oakwood Court Abbotsbury Road W14 8JX London | French | 65300550001 | ||||||
| COOMBS, Martin | Administrateur | Cain Road RG12 1HN Bracknell Amen Corner Berkshire England | England | British | 231970210001 | |||||
| COOPER, Roger Anthony | Administrateur | 2 High Peak London Road SL5 0EY Sunningdale Berkshire | Great Britain | British | 59193680002 | |||||
| DANIELS, Tanya Collette | Administrateur | Cranbourne House 1 Manor Copse Knights Enham SP10 4EF Andover Hampshire | British | 123228650001 | ||||||
| DENFORD, Michael John | Administrateur | Homewood 149 Macdonald Road GU18 5UR Lightwater Surrey | British | 79156770001 | ||||||
| EVANS, Roderick Clifford | Administrateur | Berkshire Place Wharfedale Road Winnersh RG41 5RD Wokingham 200 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 160836090001 | |||||
| IRVING, James Logan | Administrateur | Flat 17 22 Barnton Grove EH4 6EJ Edinburgh | British | 124255080001 | ||||||
| JACOBS, Nicholas Lewis | Administrateur | Yew Tree Cottage Wolverton Common RG26 5RY Tadley Hampshire | British | 77634340001 | ||||||
| LANYON, Stuart | Administrateur | 43 Briar Close B60 1GE Bromsgrove Worcestershire | British | 86721040001 | ||||||
| LISCOE, Stephen | Administrateur | 19a Cranstons Road Middle Dural New South Wales 2158 Austrailia | British New Zealand | 84274270001 | ||||||
| LUFF, Peter Brian | Administrateur | 28 Highfields MK45 5EN Westoning Bedfordshire | England | British | 299441120001 | |||||
| LUNDERVOLD, Dag | Administrateur | 11 Rosken Grove Farnham Royal SL2 3DZ Slough Berkshire | Norwegian | 69668880001 | ||||||
| MACKAY, James Richard | Administrateur | 21 Court Road PO13 9JN Lee On The Solent Hampshire | England | British | 116250290001 | |||||
| MCCRACKEN, Edward Ray | Administrateur | 2011 North Shoreline Boulevard Mountain View California Usa | American | 31586180001 | ||||||
| NUVOLETTA, Carlo | Administrateur | 19 Moorlands Close GU51 3PL Fleet Hampshire | Italian | 112734890001 | ||||||
| OSWOLD, Thomas Jay | Administrateur | 2011 North Shoreline Boulevard Mountain View California 94039-7311 America | American | 43174460001 | ||||||
| PEBWORTH, Timothy Lee | Administrateur | Butcher Drive Santa Clara California 3597 95051 Usa | Usa | Usa | 136635970001 | |||||
| PERRY, Mark William | Administrateur | 2011 North Shoreline Boulevard Mountain View California Usa | American | 31586170001 | ||||||
| ROBINSON, Timothy Michael | Administrateur | Adelaide House Adelaide Square SL4 2AH Windsor Berkshire | British | 48838740001 | ||||||
| SALTMARSH, Robert Warren | Administrateur | 175 Twin Peaks Boulevard San Fransisco 94114 California Usa | American | 65300530002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SILICON GRAPHICS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise Company | 01 nov. 2016 | Orange Street Wilmington DE19801 New Castle 120 Delaware United States | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
SILICON GRAPHICS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Créé le 22 juil. 2004 Livré le 24 juil. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its rights, title and interest, present and future, in, to and under (a) all amounts payable to the lessee under or arising out of or in respect of the contract between the lessee and csc computer services LTD dated 21 may 2004 (the "contract payment"). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security assignment | Créé le 26 sept. 2003 Livré le 14 oct. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of security all its rights, title and interest, present & future, in, to and under all amounts payable to the lessee under or arising out of or in respect of the contract between the lessee & csc computer services LTD dated 30 august 2003 (the contract payments). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Créé le 19 sept. 2002 Livré le 25 sept. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Current account: number 40665355. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Créé le 16 août 2001 Livré le 30 août 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over all deposits in and to charged deposit contract with barclays bank PLC re;-silicon graphics limited gts bid deposit deal number 77510266. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of deposit | Créé le 15 juil. 1999 Livré le 28 juil. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 15 july 1999 | |
Brèves mentions The deposit account in the name of the mortgagee with a bank in which the deposit sum is lodged in accordance with the terms of the dded of deposit of rent. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
SILICON GRAPHICS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0