CAMTRO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAMTRO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02003533
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAMTRO LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CAMTRO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAMTRO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SELF-CHANGING GEARS LIMITED10 juin 198610 juin 1986
    EAGERCRAFT LIMITED25 mars 198625 mars 1986

    Quels sont les derniers comptes de CAMTRO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CAMTRO LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CAMTRO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Warwick House PO Box 87 Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU à 15 Canada Square London E14 5GL le 03 juil. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 juin 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 sept. 2014

    État du capital au 17 sept. 2014

    • Capital: GBP 4,643,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 sept. 2013

    État du capital au 10 sept. 2013

    • Capital: GBP 4,643,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire David Stanley Parkes le 06 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Stanley Parkes le 06 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ann Louise Holding le 03 nov. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CAMTRO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Secrétaire
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    British25179240002
    HOLDING, Ann-Louise
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish73464490003
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Administrateur
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish25179240002
    DICKINSON, George Kenneth
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    Secrétaire
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    British17280390001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    Secrétaire
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    GOULDING, Jacqueline Elizabeth
    3 Sidmouth Close
    CV11 6FA Nuneaton
    Warwickshire
    Secrétaire
    3 Sidmouth Close
    CV11 6FA Nuneaton
    Warwickshire
    British49027500001
    JARMAN, Patrick Edmund
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    Secrétaire
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    British66608960002
    LANGLEY, Paul Michael
    47 Redbourn Road
    WS3 3XT Bloxwich
    West Midlands
    Secrétaire
    47 Redbourn Road
    WS3 3XT Bloxwich
    West Midlands
    British47929580002
    DICKINSON, George Kenneth
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    British17280390001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    Administrateur
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    GREENSLADE, Martin Frederick
    2 The Glade
    TN13 3HD Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    2 The Glade
    TN13 3HD Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish17633990002
    HOYLE, David John
    10 Berwick Close
    Woodloes Park
    CV34 5UF Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    10 Berwick Close
    Woodloes Park
    CV34 5UF Warwick
    Warwickshire
    British17280400001
    JARMAN, Patrick Edmund
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    Administrateur
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    British66608960002
    MITCHELL, Stuart Roger
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    New Zealand1447530001
    PEARSON, Anthony Ralph
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    British8659000001
    ROWE, Christopher Gordon
    Bluebell Grange
    Allscott
    TF6 5EB Telford
    Salop
    Administrateur
    Bluebell Grange
    Allscott
    TF6 5EB Telford
    Salop
    British113894430001
    WEBSTER, Donald James
    58 Longrood Road
    Bilton
    CV22 7RE Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    58 Longrood Road
    Bilton
    CV22 7RE Rugby
    Warwickshire
    British37379940001
    WINCH, Brian Clappison
    The Old Rectory
    Knapton Green, Knapton
    NR28 0RU North Walsham
    Norfolk
    Administrateur
    The Old Rectory
    Knapton Green, Knapton
    NR28 0RU North Walsham
    Norfolk
    EnglandBritish64371830001

    CAMTRO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to a composite guarantee and debenture dated 2 november 1998
    Créé le 15 mai 2003
    Livré le 21 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of admission to a composite guarantee and debenture dated 2 november 1998
    Créé le 15 mai 2003
    Livré le 21 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Floating charge over all undertaking property assets and revenues.
    Personnes ayant droit
    • Alvis PLC
    Transactions
    • 21 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee and debenture
    Créé le 15 mai 1995
    Livré le 25 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment and charge of registered designs and design right
    Créé le 15 mai 1995
    Livré le 25 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Brèves mentions
    The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment and charge of copyright and design rights
    Créé le 15 mai 1995
    Livré le 25 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Brèves mentions
    The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of trade marks, trade names and goodwill
    Créé le 15 mai 1995
    Livré le 25 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Brèves mentions
    The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment and charge of patents
    Créé le 15 mai 1995
    Livré le 25 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Brèves mentions
    All inventions and patents specified in form 395 together with all inventions and patents belonging to the mortgagor present and future at the date of the charge. Patent no's: 5031477. 0 420 446 (e) (X2). 2172 672. 2235663. P690 01 168.7 14889/1990. 5 031 477.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined)
    Créé le 12 juil. 1994
    Livré le 22 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Each of the Banks
    Transactions
    • 22 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined)
    Créé le 12 juil. 1994
    Livré le 22 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Each of the Banks
    Transactions
    • 22 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession and supplemental charge.
    Créé le 30 sept. 1991
    Livré le 15 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this deed.
    Brèves mentions
    (See doc M395-ref M816 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 25 juin 1990
    Livré le 11 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trade marks mortgage
    Créé le 25 juin 1990
    Livré le 11 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All trade marks and applications for trade marks as defined on form M395 reg M137.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Patents charge
    Créé le 25 juin 1990
    Livré le 11 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All inventions and patents as defined on form M395 reg M127.
    Personnes ayant droit
    • Barclayds Bank Plcd in the Deed)(For Itself and as Agent for the Banks as Define
    Transactions
    • 11 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Designs charge
    Créé le 25 juin 1990
    Livré le 11 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All designs as defined on form M395, reg M117.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of copyright
    Créé le 25 juin 1990
    Livré le 11 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All copyrights, design rights and rights defined on form M395, reg M107.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CAMTRO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 mars 2016Dissolved on
    16 juin 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0