GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED

GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02006409
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED ?

    • (5530) /

    Où se situe GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GROUPE CHEZ GERARD LIMITED09 sept. 199109 sept. 1991
    LAKEBIRD LEISURE LIMITED13 juin 198613 juin 1986
    LAKEBIND LIMITED03 avr. 198603 avr. 1986

    Quels sont les derniers comptes de GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 janv. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    GAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    32 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 oct. 2013

    26 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 23 oct. 2012

    35 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 22 mai 2012

    39 pages2.24B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    61 pages2.17B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    61 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    15 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de * 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH* le 05 déc. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Provision of articles hereby revoked 29/09/2011
    RES13
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    État du capital après une attribution d'actions au 29 sept. 2011

    • Capital: GBP 15,992,000
    4 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 29 sept. 2011

    • Capital: GBP 492,000.0
    SH01

    Comptes annuels établis au 02 janv. 2011

    20 pagesAA

    legacy

    10 pagesMG01

    Nomination de Mr Stephen Rushworth Smith en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de William Rollason en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Période comptable actuelle prolongée du 29 juin 2010 au 29 déc. 2010

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr William Rollason en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Simon George Rowe en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Phillips en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Hill en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROWE, Simon George
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8-10
    Administrateur
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8-10
    EnglandBritish68119020002
    SMITH, Stephen Rushworth
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    Administrateur
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    United KingdomBritish6894950002
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Secrétaire
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    British148079910001
    GAMBLE, Stephen
    92 Bressey Grove
    South Woodford
    E18 2HX London
    Secrétaire
    92 Bressey Grove
    South Woodford
    E18 2HX London
    British106836430001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Secrétaire
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    British75225920001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Secrétaire
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    British130983750001
    HOLDER, Ian Keith
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    Secrétaire
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    British60759970001
    ISAACSON, Laurence Ivor
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    Secrétaire
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    British2996380001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    British62321110002
    ABRAHAM, Neville Victor
    Avenue Louise 368
    1050 Bruxelles
    Belgium
    Administrateur
    Avenue Louise 368
    1050 Bruxelles
    Belgium
    British10579160003
    ABRAHAM, Neville Victor
    82 Addison Road
    W14 8ED London
    Administrateur
    82 Addison Road
    W14 8ED London
    United KingdomBritish10579160002
    BASING, Nicholas Andrew
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    Administrateur
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    EnglandBritish140766360001
    BERTORELLI, Adrian Peter
    2 Bayhurst Drive
    HA6 3SA Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    2 Bayhurst Drive
    HA6 3SA Northwood
    Middlesex
    British15898860001
    BINDER, Simon
    Flat 89
    15 Portman Square
    W1H 6LL London
    Administrateur
    Flat 89
    15 Portman Square
    W1H 6LL London
    United KingdomBritish97451910001
    BROWN, Christopher Niall Bridgmore
    Mallards
    Spade Oak Reach
    SL6 9RQ Cookham
    Berkshire
    Administrateur
    Mallards
    Spade Oak Reach
    SL6 9RQ Cookham
    Berkshire
    EnglandBritish99369900001
    DA COSTA, Michael Phillip
    Flat 4 Saint John's Lodge
    Harley Road
    NW3 3BY London
    Administrateur
    Flat 4 Saint John's Lodge
    Harley Road
    NW3 3BY London
    British26140900002
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Administrateur
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    United KingdomBritish148079910001
    EDWARDS, Terence David
    29 Morley Road
    SM3 9LN Sutton
    Surrey
    Administrateur
    29 Morley Road
    SM3 9LN Sutton
    Surrey
    British15898850001
    ENGLISH, Tina
    8 Kensington Court Place
    Kensington
    W8 5BJ London
    Administrateur
    8 Kensington Court Place
    Kensington
    W8 5BJ London
    British98725570001
    FARROW, Edmund John
    4 Park View 31 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    Administrateur
    4 Park View 31 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    British51885010001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    British75225920001
    HAND, Alan
    Ivy Cottage
    3 St Thomas Street
    OX15 0SY Deddington
    Oxfordshire
    Administrateur
    Ivy Cottage
    3 St Thomas Street
    OX15 0SY Deddington
    Oxfordshire
    Irish102272320001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Administrateur
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    EnglandBritish130983750001
    HOLDER, Ian Keith
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    Administrateur
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    British60759970001
    ISAACSON, Laurence Ivor
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    Administrateur
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    United KingdomBritish2996380001
    JELFFS-SHUCKBURGH, Deborah Ann
    6 Brook Valley
    Mid Holmwood
    RH5 4EZ Dorking
    Surrey
    Administrateur
    6 Brook Valley
    Mid Holmwood
    RH5 4EZ Dorking
    Surrey
    British77499800001
    LEDERER, John David
    272 Lillie Road
    SE6 7PX London
    Administrateur
    272 Lillie Road
    SE6 7PX London
    United KingdomBritish86140390001
    MCKAY, Nicholas Adrian Richard
    48 Rawlings Street
    Chelsea
    SW3 2LS London
    Administrateur
    48 Rawlings Street
    Chelsea
    SW3 2LS London
    British14633330001
    MILNER, Pauline Alice
    31 Roupell Street
    SE1 8TB London
    Administrateur
    31 Roupell Street
    SE1 8TB London
    United KingdomBritish51885090002
    MIRRELSON, Joseph Bernard
    107 Cheyne Walk
    SW10 0DJ Chelsea
    London
    Administrateur
    107 Cheyne Walk
    SW10 0DJ Chelsea
    London
    British40430150001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Administrateur
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    PHILLIPS, Mark Randall
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80508130001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish62321110002
    ROLLASON, William
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    Administrateur
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    United KingdomBritish140347580001
    WHITLEY, Clare Elizabeth
    42 Cornwall Gardens
    SW7 4AA London
    Administrateur
    42 Cornwall Gardens
    SW7 4AA London
    British48012620002

    GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A supplemental security, accession and confirmation deed
    Créé le 22 sept. 2011
    Livré le 28 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The chargor, with full title guarantee, in favour of the security trustee (as trustee for the finance parties), hereby respectively charged on the terms set out in the relevant charging clause of the relevant security documents its assets as more specifically referred to in the relevant security documents, the secured liabilities see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 17 juil. 2009
    Livré le 27 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 28 sept. 2006
    Livré le 05 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each security provider to the senior finance parties and the mezzanine finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 15 déc. 2005
    Livré le 17 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units 35, 36 and 45 the market covent garden london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 17 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 22 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental legal charge
    Créé le 15 déc. 2005
    Livré le 16 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The mortgaged property being unit 35, 36 and 45 the market covent garden london, the plant and machinery, any goodwill, rental and other money payable and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Starlight Investments Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 16 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 28 sept. 2005
    Livré le 05 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property at 1 watling street, st paul's, london t/no NGL800172. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 août 2005
    Livré le 02 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Unit 6 whitehouse apartments, 9 belvedere road, southbank t/n TGL165663, hasilwood house, 60/64 bishopsgate t/n NGL751095 and 119/120 chancery lane t/n NGL767272 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Starlight Investments Limited (Security Trustee)
    Transactions
    • 02 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 mai 2005
    Livré le 27 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 27 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 05 nov. 2003
    Livré le 15 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    £62,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    An account set up pursuant to a rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • Personal Pension Management Limited
    Transactions
    • 15 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 mai 2003
    Livré le 09 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 oct. 2001
    Livré le 30 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 24 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Transfer deed
    Créé le 29 oct. 1993
    Livré le 15 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charges upon; all the property and/or assets of the company listed on the schedule together with all buildings,fixtures and fixed plant and machinery. All other present and f/h and l/h property of the company all the company's present and future goodwill and uncalled capital. Floating charges upon all theundertaking and assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 août 1989
    Livré le 22 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part basement ground & first floors 11/13 frith st. & 3/5 bateman st. London W1 with fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 22 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 août 1989
    Livré le 22 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Ground floor & basement 39, panton st. London SW1 fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 22 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 août 1989
    Livré le 22 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    44A & 44B floral street london WC2 fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 22 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 août 1989
    Livré le 17 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 17 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juil. 1989
    Livré le 21 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Twenties publis house, 39, ranelagh grove, london, SW1.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 21 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 09 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juil. 1989
    Livré le 20 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part ground floor and whole of basement, 119/120 chancery lane, london WC2. Together with the fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any and stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 20 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juil. 1989
    Livré le 20 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part 31 dover street london W1 t/n ngl 339791 together with fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 20 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 juil. 1989
    Livré le 20 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    8 charlotte street, fitzroy square, st pancras, london W1. T/n 64653 together with fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any and stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transactions
    • 20 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1988
    Livré le 26 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    44A floral street london WC2.
    Transactions
    • 26 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1988
    Livré le 26 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    11-13 frith street london W1.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1988
    Livré le 26 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    39 panton street london SW1.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 15 févr. 1988
    Livré le 26 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 12 août 1987
    Livré le 26 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/as being 11/13 frith street and 3/5 bateman street, london W1 including the entirley of the property comprised is a lease dated 14.10.86 of all buildings & fixtures thereon & by way of assignment the goodwill of the business carried on at the above property & the full benefit of all present and future licences held in connection with the said business or any other business carried on at the above.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 1987Enregistrement d'une charge

    GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 nov. 2011Administration started
    24 oct. 2012Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew David Smith
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DateType
    24 oct. 2012Commencement of winding up
    16 août 2014Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew David Smith
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0