SUPERIOR FOOD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUPERIOR FOOD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02006417
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUPERIOR FOOD LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SUPERIOR FOOD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SUPERIOR FOOD LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SUPERIOR FOODS LIMITED02 mai 199602 mai 1996
    SPURHART LIMITED03 avr. 198603 avr. 1986

    Quels sont les derniers comptes de SUPERIOR FOOD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour SUPERIOR FOOD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Martin Johnson en tant que directeur le 03 juin 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Diarmuid Brendan Conifrey en tant que directeur le 24 juin 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Diarmuid Brendan Conifrey en tant qu'administrateur le 08 avr. 2020

    2 pagesAP01

    Ordonnance du tribunal

    S1096 Court Order to Rectify
    6 pagesOC

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018

    22 pagesAA

    legacy

    pagesANNOTATION

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 sept. 2017

    22 pagesAA

    legacy

    2 pagesAGREEMENT2

    legacy

    47 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2017 au 30 sept. 2017

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Mark Ian Tentori en tant que directeur le 27 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gavin Cox en tant que secrétaire le 08 mars 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Gavin Eliot Cox en tant que directeur le 07 mars 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Martin Johnson en tant qu'administrateur le 25 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 févr. 2016

    État du capital au 09 févr. 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Mr Mark Ian Tentori en tant qu'administrateur le 06 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Agreement 25/09/2015
    RES13

    Qui sont les dirigeants de SUPERIOR FOOD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Secrétaire
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756710001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Secrétaire
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150500890001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    Secrétaire
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    116685100001
    CHISAMBI, Rodgers Yalamila
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Administrateur
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Zambian77986900001
    CONIFREY, Diarmuid Brendan
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Administrateur
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandIrish268799160001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Administrateur
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritish153840250001
    FEE, Paul
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    Administrateur
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    British55281590001
    GUY, David Simon
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British119214340001
    HALL, Fraser Scott
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British4578740001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish83660790002
    JOHNSON, Martin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Administrateur
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritish140167360001
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritish132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish157009150001
    MELLORS, William Peter Stewart
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    British107055640001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Administrateur
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritish51784930002
    NELSON, Finlay Macarthur
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    Administrateur
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    EnglandBritish132363820001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Administrateur
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Administrateur
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Administrateur
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    British96978470001
    SINCLAIR, John Frederick
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    Administrateur
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    British17581780001
    SWAINSTON, Keith Graham
    19 Bedford Street
    SG5 2JG Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    19 Bedford Street
    SG5 2JG Hitchin
    Hertfordshire
    British81821290001
    TAYLOR, Agatha
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British58350880001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    TENTORI, Mark Ian
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Administrateur
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritish119564310001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Administrateur
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    EnglandBritish63844650001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    British37845970003
    WEBB, Robert John
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    Administrateur
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    British65669490001
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Administrateur
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritish232132390001
    WORT, Edward George
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    Administrateur
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    British77987180001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SUPERIOR FOOD LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Superior Food Group Limited
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    06 avr. 2016
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies
    Numéro d'enregistrement05288249
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    SUPERIOR FOOD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 05 mars 2015
    Livré le 11 mars 2015
    En cours
    Brève description
    None.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 11 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 31 mai 2013
    Livré le 07 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to superior food limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of superior food limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 07 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 31 mai 2013
    Livré le 05 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Punjab National Bank (International) Limited
    Transactions
    • 05 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 06 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 11 avr. 2012
    Livré le 14 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 11 avr. 2012
    Livré le 14 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transactions
    • 14 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 avr. 2008
    Livré le 02 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 02 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture accession deed
    Créé le 16 févr. 2007
    Livré le 05 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to the property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)(the Security Agent)
    Transactions
    • 05 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 14 mars 2006
    Livré le 01 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The tenant's interest in all the monies standing to the credit of the account including all interest accruing thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Brixton (Great Western,Southall) 1 Limited
    Transactions
    • 01 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Chattel mortgage
    Créé le 31 janv. 2006
    Livré le 09 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 home counties storage system 17D mezzanine floor, 1 home counties storage system 17C mezzanine floor, 1 ima cooling system cold room 17A, for details of further chattels charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 09 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 08 janv. 2004
    Livré le 10 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 10 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 mars 1999
    Livré le 01 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 avr. 1994
    Livré le 05 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 8 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 avr. 1994
    Livré le 05 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 4 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 avr. 1994
    Livré le 05 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 2 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 févr. 1994
    Livré le 19 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 26 juil. 1990
    Livré le 31 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 8 featherstone industrial estate dominion road southall middx and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 sept. 1989
    Livré le 29 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit number 2 feather stone industrial estate southall L.B. of ealing unit number of feather stone industrial estate southall L.B. of ealing and proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 03 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0