LARGEDOUBLE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLARGEDOUBLE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02009038
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LARGEDOUBLE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe LARGEDOUBLE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Micheldever Tyre Services Limited Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LARGEDOUBLE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour LARGEDOUBLE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2018 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Belmont House Station Way Crawley RH10 1JA

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Belmont House Station Way Crawley RH10 1JA

    1 pagesAD02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2018 au 31 déc. 2017

    1 pagesAA01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2017

    9 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 20 mars 2018 au 31 mars 2017

    1 pagesAA01

    Comptes d'exonération totale établis au 20 mars 2017

    9 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2017 au 20 mars 2017

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Philip Raymond Stoddart en tant que directeur le 21 mars 2017

    2 pagesTM01

    Nomination de Jonathan Robert Cowles en tant que secrétaire le 21 mars 2017

    3 pagesAP03

    Nomination de Mr Duncan Stewart Wilkes en tant qu'administrateur le 21 mars 2017

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Jonathan Robert Cowles en tant qu'administrateur le 21 mars 2017

    3 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Tiers Cross Haverfordwest Pembrokeshire SA62 3DB à Micheldever Tyre Services Limited Micheldever Station Andover Road Winchester Hampshire SO21 3AP le 05 avr. 2017

    2 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 020090380016 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 020090380015 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 10 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LARGEDOUBLE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COWLES, Jonathan Robert
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    Secrétaire
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    228670660001
    COWLES, Jonathan Robert
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    Administrateur
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    EnglandBritish122658610002
    WILKES, Duncan Stewart
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    Administrateur
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    EnglandBritish75861610001
    FLANNERY, Karen
    Redlands Cottage
    Hasguard Cross
    SA62 3SJ Haverfordwest
    Pembrokeshire
    Secrétaire
    Redlands Cottage
    Hasguard Cross
    SA62 3SJ Haverfordwest
    Pembrokeshire
    British125088880001
    STODDART, Andrew Michael
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    Secrétaire
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    British6030590001
    STODDART, Sara Jane
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Dyfed
    Secrétaire
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Dyfed
    British41000880001
    SUTTON, Lucy Marie
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Pembrokeshire
    Secrétaire
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Pembrokeshire
    British81443870001
    STODDART, Andrew Michael
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    Administrateur
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    British6030590001
    STODDART, Joan, Director
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    Administrateur
    Talbenny Hall Farm
    Talbenny
    SA62 3XB Haverfordwest
    Dyfed
    British6030600001
    STODDART, Philip Raymond
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Oakleigh House
    Dyfed
    United Kingdom
    Administrateur
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Oakleigh House
    Dyfed
    United Kingdom
    WalesBritish125088870001
    STODDART, Sara Jane
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Dyfed
    Administrateur
    Oakdene
    Tiers Cross
    SA62 3DB Haverfordwest
    Dyfed
    British41000880001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LARGEDOUBLE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services
    England
    21 mars 2017
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01817398
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mr Philip Raymond Stoddart
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    10 mars 2017
    Micheldever Station
    Andover Road
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Tyre Services Limited
    Hampshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Wales
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    LARGEDOUBLE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 mai 2013
    Livré le 21 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 mai 2013
    Livré le 10 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The property at: leasehold property known as pembroke depot- 4/5 kingswood trading estate, pembroke dock, pembrokeshire under title number: CYM478197.. With the benefit of all rights, licences, guarantees, rent, deposits contracts, deeds, undertakings and warranties relating to the property:. Any shares or membership rights in any management company for the property;. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property;. Any rental and other money payable under any lease, licence or other interest created in respect of the property; and. All other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 10 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 10 nov. 2011
    Livré le 19 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H unit 3 parc gwynfryn industrial estate crymych pembrokeshire together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 27 avr. 2011
    Livré le 30 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H part of land lying to the north of a road leading from robeston cross to tiers cross haverfordwest t/n part CYM239886, together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 23 déc. 2009
    Livré le 13 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H warehouse east and west at london road mall pembroke dock pembrokeshire together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 23 déc. 2009
    Livré le 24 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £30,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Warehouse east & west the london road mall penbroke dock.
    Personnes ayant droit
    • Pendfro Limited
    Transactions
    • 24 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 15 déc. 2006
    Livré le 05 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Bowens hardware store maenclochog clyderwen pembrokeshire t/no CYM306933. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 29 nov. 2002
    Livré le 04 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as or being the industrial plot at brookside estate withybush haverfordwest title number WA908516. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 22 nov. 2002
    Livré le 04 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as central garage tiers cross haverfordwest title numbers WA759111 and WA764539. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 15 oct. 2002
    Livré le 19 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 19 févr. 1999
    Livré le 02 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a 1/3 acre of land at withybush industrial estate haverfordwest. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 07 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a edwards garage, tiers cross, haverfordwest, dyfed. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 07 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a central garage, tiers cross, haverfordwest, dyfed. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 07 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 mai 1995
    Livré le 12 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-property k/a central garage old hakin road tiers cross haverfordwest dyfed t/n-WA690257 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 07 juil. 1987
    Livré le 14 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land farmely part of talbenry hall farm talberry dyfed. And/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0