LTG GATESHEAD GROUP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLTG GATESHEAD GROUP PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 02010022
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LTG GATESHEAD GROUP PLC ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe LTG GATESHEAD GROUP PLC ?

    Adresse du siège social
    c/o IMAGELINX UK LTD
    Julias Way Station Park Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LTG GATESHEAD GROUP PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CRABTREE GROUP PLC21 juin 199321 juin 1993
    SOMERSET TRUST PLC10 juil. 199210 juil. 1992
    CHILDREN'S MEDICAL CHARITY INVESTMENT TRUST PLC14 avr. 198614 avr. 1986

    Quels sont les derniers comptes de LTG GATESHEAD GROUP PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour LTG GATESHEAD GROUP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    2 pagesAA

    Nomination de Mrs Louise Palmer en tant qu'administrateur le 16 nov. 2010

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mars 2012

    État du capital au 08 mars 2012

    • Capital: GBP 2,028,329.9
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de C/0 Imagelinx Uk Ltd Julias Way Station Park Lowmoor Road Kirkby in Ashfield Nottinghamshire NG17 5HN le 08 mars 2012

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 févr. 2011

    13 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Albert Klein en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Albert Kenngott Klein le 01 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    11 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    7 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de LTG GATESHEAD GROUP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PALMER, Louise
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    Secrétaire
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    British119011320002
    PALMER, Louise
    c/o Imagelinx Uk Ltd
    Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    Julias Way Station Park
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Imagelinx Uk Ltd
    Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    Julias Way Station Park
    United Kingdom
    United KingdomBritish119011320002
    RAE, Alistair Kynoch
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    Administrateur
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    United KingdomBritish53806830002
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Secrétaire
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    German69193840001
    CHESSER, David
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    Secrétaire
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    British64149560002
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British30827780001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    British94273950001
    OURY, Richard Anthony
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    Secrétaire
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    British29821230002
    ROWSON, Peter Aston
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    Secrétaire
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    British94699120001
    C S INVESTMENTS LIMITED
    125 High Holborn
    WC1V 6PY London
    Secrétaire
    125 High Holborn
    WC1V 6PY London
    4852550001
    THROGMORTON SECRETARIES LIMITED
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    80839850001
    ARMSTRONG, Michael John Lloyd
    Moor Mill Farm
    Lydeard,St Lawrence
    TA4 3RG Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Moor Mill Farm
    Lydeard,St Lawrence
    TA4 3RG Taunton
    Somerset
    British48330740002
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Administrateur
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    German69193840001
    BARNETT, Joel, The Right Honourable Lord Barnett
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish2883500001
    CHESSER, David
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    Administrateur
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    EnglandBritish64149560002
    COOPER, Matthew
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    Administrateur
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    United KingdomBritish35122920001
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Administrateur
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    EnglandBritish30827780001
    FELLERMAN, Paul
    38 Sherwood Road
    Hendon
    NW4 1AD London
    Administrateur
    38 Sherwood Road
    Hendon
    NW4 1AD London
    British10266750001
    FLETCHER, Alan Thomas
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    Administrateur
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    British14669590001
    HARGRAVE, Stephen Thomas
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    Administrateur
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    EnglandBritish60918490001
    HOLMES, John Edwin
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    British42461820001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Administrateur
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    EnglandBritish94273950001
    JOHNSON, Luke Oliver
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    Administrateur
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    British56699270001
    KLEIN, Albert Kenngott
    C/0 Imagelinx Uk Ltd
    Julias Way Station Park
    NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    Administrateur
    C/0 Imagelinx Uk Ltd
    Julias Way Station Park
    NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    GermanyGerman69826640001
    LEHRER, Abraham Mayir
    13 Haslemere Gardens
    N3 3EA London
    Administrateur
    13 Haslemere Gardens
    N3 3EA London
    British10008800001
    LEWINSOHN, Max Robert
    Tanyard Manor
    Horsted Lane
    RH19 4HY Sharpthorne
    Sussex
    Administrateur
    Tanyard Manor
    Horsted Lane
    RH19 4HY Sharpthorne
    Sussex
    United KingdomBritish17400002
    MOWINCKEL, John Crostarosa, Mr.
    Flat 9 30 Bramham Gardens
    SW5 0HE London
    Administrateur
    Flat 9 30 Bramham Gardens
    SW5 0HE London
    United KingdomAmerican42840430001
    NAPOLEON, Edward
    929 N Astor 1502
    Milwaukee Wi
    53202
    Usa
    Administrateur
    929 N Astor 1502
    Milwaukee Wi
    53202
    Usa
    American50486960002
    ODELL, Frank William
    7 Ham Farm Road
    Ham Common
    TW10 5ND Richmond
    Surrey
    Administrateur
    7 Ham Farm Road
    Ham Common
    TW10 5ND Richmond
    Surrey
    British2081870001
    ORR, David Alexander, Sir
    Home Farm House
    Shackleford
    GU8 6AH Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Home Farm House
    Shackleford
    GU8 6AH Godalming
    Surrey
    British38973090001
    OURY, Richard Anthony
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    Administrateur
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    EnglandBritish29821230002
    PAUL, Swraj, Dr
    Caparo House 103 Baker Street
    W1M 1FD London
    Administrateur
    Caparo House 103 Baker Street
    W1M 1FD London
    British40016170001
    PERLOFF, Andrew Stewart
    Friars Mead Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3RA Borehamwood
    Hertfordshire
    Administrateur
    Friars Mead Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3RA Borehamwood
    Hertfordshire
    EnglandBritish1474150001
    ROGERS, Douglas Ernest
    46 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    46 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    British32445690002
    STEVENSON, Samuel
    149 Pavilion Road
    SW1X 0BJ London
    Administrateur
    149 Pavilion Road
    SW1X 0BJ London
    British2506760001

    LTG GATESHEAD GROUP PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed between the company (1) crabtree holdings (us) limited (2) crabtree holdings limited (3) crabtree of gateshead limited (4) and landesbank baden-wurttenberg (the bank) (2)
    Créé le 12 juil. 1999
    Livré le 02 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    (A) the secured parties have made available to the companies a loan facility of up to dem 19,800,000 on the terms set out in a facility agreement (the" crabtree facilities agreement") dated 11 november 1998 made between the companies as borrower (1) ltg technologies PLC as guarantor (2) and the chargee (3) for the purpose of refinancing existing loan facilities of the companies.(b) the obligations of the companies to the secured parties under or pursuant to inter alia the crabtree facilities agreement are secured by a composite guarantee and debenture dated 15 december 1998
    Brèves mentions
    Pursuant to the supplemental deed the debenture has been amended so that schedule 2 (properties),schedule 3 (fixed plant and machinery) and schedule 4 (intellectual property rights) to the debenture are deleted in their entirety and replaced by the respective schedules set out in annexure a of the supplemental deed. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Baden-Wurttenberg (The Successor Entity Following the Merger on 1 January 1999 of Landesgirokasse Offentliche Bank Und Landessparkasse,Sudwestdeutsche Landesbank Girozentrale and Landeskreditbank Baden Wurttenberg)
    Transactions
    • 02 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture between crabtree group PLC (1), crabtree holdings (us) limited (2), crabtree holdings limited (3), crabtree of gateshead limited (4) and landesgirokasse offentliche bank und landessparkasse (the "chargee")(5)
    Créé le 15 déc. 1998
    Livré le 22 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the chargee under or pursuant to the "secured documents" (as defined) together and each as it may from time to time be amended varied novated supplemented or replaced
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Landesgirokasse Offentliche Bank Und Landessparkasse
    Transactions
    • 22 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 nov. 1995
    Livré le 05 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 13 oct. 1993
    Livré le 28 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all the deposits, together with all interest from time to time accruing thereon, details of charged deposit contract(s)-barclays bank PLC re spmerset trust PLC (now called crabtree group PLC) gts bid deposit bid number 7568760 (for full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 23 juil. 1993
    Livré le 12 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all the "deposit (s)", together with all interest from time to time accruing thereon. Details of charged account(s)-barclays bank PLC re crabtree group PLC, bid deposit bid no: 62011466 (for full details see from 395).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 21 juin 1993
    Livré le 12 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC re somerset trust PLC gts bid deposit bid no 7568760. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0