POWRIE CASTLE PROPERTIES LIMITED

POWRIE CASTLE PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPOWRIE CASTLE PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02010343
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de POWRIE CASTLE PROPERTIES LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe POWRIE CASTLE PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Hamilton Avenue
    L5 4RT Liverpool
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de POWRIE CASTLE PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FIRESPREAD LIMITED15 avr. 198615 avr. 1986

    Quels sont les derniers comptes de POWRIE CASTLE PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour POWRIE CASTLE PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Changement d'adresse du siège social de Becket House 1 Lambeth Palace Road London SE1 7EU le 14 avr. 2010

    2 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    État du capital au 17 déc. 2009

    • Capital: GBP 100
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2009

    4 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    6 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2008

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2007

    4 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2006

    5 pagesAA

    legacy

    6 pages395

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2005

    5 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    1 pages287

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    pages363(353)

    legacy

    pages363(190)

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2004

    5 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2003

    6 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    6 pages363s

    Qui sont les dirigeants de POWRIE CASTLE PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GROGAN, Dawn
    4 Loftus Place
    Copperwood Point
    DD3 9TF Dundee
    Secrétaire
    4 Loftus Place
    Copperwood Point
    DD3 9TF Dundee
    British49509230002
    MCDONALD, Ian Young
    1 Kerrs Lane
    Lochee
    DD2 3HA Dundee
    Tayside
    Administrateur
    1 Kerrs Lane
    Lochee
    DD2 3HA Dundee
    Tayside
    British1131420001
    MCDONALD, Ian Young
    1 Kerrs Lane
    Lochee
    DD2 3HA Dundee
    Tayside
    Secrétaire
    1 Kerrs Lane
    Lochee
    DD2 3HA Dundee
    Tayside
    British1131420001
    PATERSON, Elaine Phyllis
    Inglewood
    13 Reform Street
    DD6 9HX Tayport
    Fife
    Secrétaire
    Inglewood
    13 Reform Street
    DD6 9HX Tayport
    Fife
    British332810004
    MCDONALD, Jason
    1 Kerrs Lane
    Lochee
    DD2 3HA Dundee
    Tayside
    Administrateur
    1 Kerrs Lane
    Lochee
    DD2 3HA Dundee
    Tayside
    British38122380001
    PATERSON, Elaine Phyllis
    Inglewood
    13 Reform Street
    DD6 9HX Tayport
    Fife
    Administrateur
    Inglewood
    13 Reform Street
    DD6 9HX Tayport
    Fife
    ScotlandBritish332810004
    PATERSON, Raymond
    Seabourne House (East)
    96 Monifieth Road Broughty Ferry
    DD5 2SJ Dundee
    Administrateur
    Seabourne House (East)
    96 Monifieth Road Broughty Ferry
    DD5 2SJ Dundee
    British1131430002

    POWRIE CASTLE PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 20 avr. 2006
    Livré le 29 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 22ND january 1996
    Créé le 16 janv. 1996
    Livré le 26 janv. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Westmost top floor flatted dwellinghouse 71 perth road dundee and westmost first floor flatted dwellinghouse 71 perth road dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security presented for registration in scotland
    Créé le 22 déc. 1995
    Livré le 05 janv. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a personal bond dated 14TH november 1995
    Brèves mentions
    First floor former restaurant premises at 30/32 seagate dundee and ground floor "take away" premises at 30 seagate dundee and basement below.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Créé le 07 juin 1994
    Livré le 15 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Westmost and eastmost first floor flats, westmost and eastmost second floor flats and eastmost third floor flat, 18 arbroath road, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Créé le 24 mai 1994
    Livré le 04 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Eastmost second floor flat and westmost second floor flats, 28 arbroath road, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Créé le 06 mai 1994
    Livré le 18 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Westmost top floor flat and eastmost top floor flat, 14 arthurstone terrace, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of offset
    Créé le 20 juil. 1992
    Livré le 10 août 1992
    En cours
    Montant garanti
    All monies due from temple park properties LTD,dudhope investments LTD,dudhope properties LTD and dudhope developments LTD to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The balances at credit of any acounts held by the chargee in the name of powrie castle properties LTD.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 août 1992Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0