INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02013410 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ?
Adresse du siège social | Allen House 1 Westmead Road Sutton SM1 4LA Surrey |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 11 pages | 4.72 | ||||||||||
Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché | 6 pages | 4.20 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 4th Floor, Neville House Waterloo Street Birmingham West Midlands B2 5UF England le 20 mai 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Grahame Griffiths en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter David Hoole le 13 déc. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2010 au 30 sept. 2010 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed interchange group LIMITED\certificate issued on 03/11/10 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes modifiés pour une petite société jusqu'au 31 mars 2009 | 10 pages | AAMD | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2009 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur David Burrows le 01 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Peter Michael Neville le 01 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Coley & Tilley Neville House Waterloo Street Birmingham West Midlands B2 5UF le 03 déc. 2009 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2008 | 10 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Coley & Tilley Neville House Waterloo Street Birmingham West Midlands B2 5UF England le 25 nov. 2009 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Interchange Park Newport Pagnell Buckinghamshire MK16 9PS le 24 nov. 2009 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2007 | 21 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c |
Qui sont les dirigeants de INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURROWS, David, Mr. | Administrateur | 37 Broom Lane S60 3EL Rotherham South Yorkshire | England | British | R & D Director | 119849000001 | ||||
FAIRBURN, Barry | Administrateur | 18 Glossop Way SG15 6YG Arlesey Bedfordshire | England | British | Company Director | 23452410002 | ||||
HODGSON, Kenneth William | Administrateur | 14 Augusta Avenue Collingtree Park NN4 0XP Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | Co Director | 91739820001 | ||||
HOOLE, Peter David | Administrateur | Greenways Bow Brickhill MK17 9JP Milton Keynes 28 Buckinghamshire England | England | British | Co Director | 13747930002 | ||||
JONES, Phillip James | Administrateur | Silverdale Old Charlton Road SG5 2AJ Hitchin Hertfordshire | England | British | Company Director | 36091520004 | ||||
NEVILLE, Peter Michael | Administrateur | 22 Nottingham Road NG12 5FD Keyworth Nottinghamshire | United Kingdom | British | Director | 119849190001 | ||||
FRANKLIN, Ian Wynne | Secrétaire | 11 Grassington Bancroft MK13 0QJ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 4550230001 | ||||||
GRIFFITHS, Grahame Nigel | Secrétaire | 19 Cartland Road Kings Heath B14 7NS Birmingham West Midlands | British | Solicitor | 69984600001 | |||||
O'DONNELL, John Gerard | Secrétaire | 39 Milton Drive MK16 9AS Newport Pagnell Buckinghamshire | Irish | Accountant | 37900960001 | |||||
ELLIS, Brian James | Administrateur | The Old Barn Walsh Lane Meriden CV7 7JY Coventry Warwickshire | British | Co Director | 4923400002 | |||||
FRANKLIN, Ian Wynne | Administrateur | 11 Grassington Bancroft MK13 0QJ Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | Co Director | 4550230001 | ||||
HOPEWELL, Rosalind Anne | Administrateur | 24 Holland Road Ampthill MK45 2RS Bedford Bedfordshire | British | Director | 23452430002 | |||||
LOVETT, Paul John | Administrateur | Braeside Lovelace Avenue B91 3JR Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 40369780001 | ||||
RAND, Michael Guy | Administrateur | Widdrington Lodge Chiltern Hill, Chalfont St. Peter SL9 9TX Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Company Director | 75405790001 |
INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deposit agreement to secure own liabilities | Créé le 10 juil. 2002 Livré le 12 juil. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The account with the bank denominated in sterling designated ltsb re interchange group LTD and numbered 03367628 and any account(s) for the time being replacing the same. And all deposits with the bank's treasury division in the name of the bank re the company in whatever currency denominated. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment of intellectual property rights by way of security | Créé le 22 avr. 1996 Livré le 08 mai 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All copyrights,know-how and other rights,title and interest whatsoever and goodwill of business thereto; all trade/service marks in relation to the software listed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Credit agreement | Créé le 20 févr. 1992 Livré le 28 févr. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti £68,596.80 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in the sums payable under the insurances (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Collateral debenture | Créé le 22 janv. 1992 Livré le 28 janv. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due from interchange group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions See form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 28 mai 1991 Livré le 05 juin 1991 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 24 janv. 1991 Livré le 31 janv. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge on f/h & l/h properties. Fixed charge over goodwill uncalled capital. Book debts & other debts. Floating charge over stock-in-trade property, assets and undertaking. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Collateral debenture | Créé le 24 janv. 1991 Livré le 31 janv. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from lilypush limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Fixed charge on f/h & l/h properties. Fixed charge over goodwill, uncalled capital book debts & other debts. Floating charge over stock-in-trade, property, assets and undertaking. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0