INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED

INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02013410
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    • (7210) /
    • (7250) /
    • (7260) /

    Où se situe INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Allen House 1 Westmead Road
    Sutton
    SM1 4LA Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTERCHANGE GROUP LIMITED16 nov. 199316 nov. 1993
    INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED08 févr. 199108 févr. 1991
    CIL ENGINEERING LIMITED14 janv. 198714 janv. 1987
    COMPUTER INVESTMENTS (ENGINEERING) LIMITED27 juin 198627 juin 1986
    EXTRACOMP MARKETING LIMITED23 avr. 198623 avr. 1986

    Quels sont les derniers comptes de INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    11 pages4.72

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 16 mai 2011

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de 4th Floor, Neville House Waterloo Street Birmingham West Midlands B2 5UF England le 20 mai 2011

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Grahame Griffiths en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 févr. 2011

    État du capital au 07 févr. 2011

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter David Hoole le 13 déc. 2010

    2 pagesCH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2010 au 30 sept. 2010

    1 pagesAA01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed interchange group LIMITED\certificate issued on 03/11/10
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name03 nov. 2010

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes modifiés pour une petite société jusqu'au 31 mars 2009

    10 pagesAAMD

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Burrows le 01 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter Michael Neville le 01 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Coley & Tilley Neville House Waterloo Street Birmingham West Midlands B2 5UF le 03 déc. 2009

    1 pagesAD01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2008

    10 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Coley & Tilley Neville House Waterloo Street Birmingham West Midlands B2 5UF England le 25 nov. 2009

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Interchange Park Newport Pagnell Buckinghamshire MK16 9PS le 24 nov. 2009

    1 pagesAD01

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    21 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURROWS, David, Mr.
    37 Broom Lane
    S60 3EL Rotherham
    South Yorkshire
    Administrateur
    37 Broom Lane
    S60 3EL Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishR & D Director119849000001
    FAIRBURN, Barry
    18 Glossop Way
    SG15 6YG Arlesey
    Bedfordshire
    Administrateur
    18 Glossop Way
    SG15 6YG Arlesey
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director23452410002
    HODGSON, Kenneth William
    14 Augusta Avenue
    Collingtree Park
    NN4 0XP Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    14 Augusta Avenue
    Collingtree Park
    NN4 0XP Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishCo Director91739820001
    HOOLE, Peter David
    Greenways
    Bow Brickhill
    MK17 9JP Milton Keynes
    28
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Greenways
    Bow Brickhill
    MK17 9JP Milton Keynes
    28
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishCo Director13747930002
    JONES, Phillip James
    Silverdale
    Old Charlton Road
    SG5 2AJ Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    Silverdale
    Old Charlton Road
    SG5 2AJ Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director36091520004
    NEVILLE, Peter Michael
    22 Nottingham Road
    NG12 5FD Keyworth
    Nottinghamshire
    Administrateur
    22 Nottingham Road
    NG12 5FD Keyworth
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector119849190001
    FRANKLIN, Ian Wynne
    11 Grassington
    Bancroft
    MK13 0QJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    11 Grassington
    Bancroft
    MK13 0QJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British4550230001
    GRIFFITHS, Grahame Nigel
    19 Cartland Road
    Kings Heath
    B14 7NS Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    19 Cartland Road
    Kings Heath
    B14 7NS Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor69984600001
    O'DONNELL, John Gerard
    39 Milton Drive
    MK16 9AS Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    39 Milton Drive
    MK16 9AS Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    IrishAccountant37900960001
    ELLIS, Brian James
    The Old Barn Walsh Lane
    Meriden
    CV7 7JY Coventry
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old Barn Walsh Lane
    Meriden
    CV7 7JY Coventry
    Warwickshire
    BritishCo Director4923400002
    FRANKLIN, Ian Wynne
    11 Grassington
    Bancroft
    MK13 0QJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    11 Grassington
    Bancroft
    MK13 0QJ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCo Director4550230001
    HOPEWELL, Rosalind Anne
    24 Holland Road
    Ampthill
    MK45 2RS Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    24 Holland Road
    Ampthill
    MK45 2RS Bedford
    Bedfordshire
    BritishDirector23452430002
    LOVETT, Paul John
    Braeside Lovelace Avenue
    B91 3JR Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Braeside Lovelace Avenue
    B91 3JR Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director40369780001
    RAND, Michael Guy
    Widdrington Lodge
    Chiltern Hill, Chalfont St. Peter
    SL9 9TX Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Widdrington Lodge
    Chiltern Hill, Chalfont St. Peter
    SL9 9TX Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director75405790001

    INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 10 juil. 2002
    Livré le 12 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The account with the bank denominated in sterling designated ltsb re interchange group LTD and numbered 03367628 and any account(s) for the time being replacing the same. And all deposits with the bank's treasury division in the name of the bank re the company in whatever currency denominated.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of assignment of intellectual property rights by way of security
    Créé le 22 avr. 1996
    Livré le 08 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All copyrights,know-how and other rights,title and interest whatsoever and goodwill of business thereto; all trade/service marks in relation to the software listed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 08 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 20 févr. 1992
    Livré le 28 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £68,596.80 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the sums payable under the insurances (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 28 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 22 janv. 1992
    Livré le 28 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from interchange group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 28 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 28 mai 1991
    Livré le 05 juin 1991
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 05 juin 1991Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 24 janv. 1991
    Livré le 31 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on f/h & l/h properties. Fixed charge over goodwill uncalled capital. Book debts & other debts. Floating charge over stock-in-trade property, assets and undertaking.
    Personnes ayant droit
    • Granada Computer Services (UK) Limited
    Transactions
    • 31 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 14 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 24 janv. 1991
    Livré le 31 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from lilypush limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed charge on f/h & l/h properties. Fixed charge over goodwill, uncalled capital book debts & other debts. Floating charge over stock-in-trade, property, assets and undertaking.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 31 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    INTERCHANGE COMPUTER SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 mai 2011Commencement of winding up
    23 nov. 2012Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Martin Charles Armstrong
    Turpin Barker Armstrong
    Allen House
    SM1 4LA One Westmead Road
    Sutton Surrey
    practitioner
    Turpin Barker Armstrong
    Allen House
    SM1 4LA One Westmead Road
    Sutton Surrey

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0