CAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED

CAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02014522
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe CAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NWS INSURANCE SERVICES LIMITED01 févr. 198801 févr. 1988
    WHITESHIELD INSURANCE SERVICES LIMITED20 janv. 198820 janv. 1988
    WHITESHIELD LIMITED18 sept. 198618 sept. 1986
    IBOS FLEETLEASE LIMITED28 juil. 198628 juil. 1986
    TWICEPAGE LIMITED28 avr. 198628 avr. 1986

    Quels sont les derniers comptes de CAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Horner le 24 janv. 2019

    2 pagesCH01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 juin 2018

    9 pagesLIQ03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom à Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Trinity Road Halifax West Yorkshire HX1 2RG à 1 More London Place London SE1 2AF le 27 juil. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 juin 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    4 pagesAA

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    1 pagesAD03

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 févr. 2016

    État du capital au 01 févr. 2016

    • Capital: GBP 2,500
    SH01

    Cessation de la nomination de Hbos Directors Limited en tant que directeur le 14 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Anthony Kevin Condon en tant qu'administrateur le 14 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Horner le 13 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard Horner le 27 oct. 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 févr. 2015

    État du capital au 03 févr. 2015

    • Capital: GBP 2,500
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 févr. 2014

    État du capital au 04 févr. 2014

    • Capital: GBP 2,500
    SH01

    Cessation de la nomination de James Carson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard Horner en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de CAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    73512200003
    CONDON, Anthony Kevin
    Canons Way
    BS99 7LB Bristol
    Canons House
    United Kingdom
    Administrateur
    Canons Way
    BS99 7LB Bristol
    Canons House
    United Kingdom
    United KingdomBritish157016950001
    HORNER, Richard
    PO BOX 112
    Canons Way
    BS99 7LB Bristol
    Canons House
    England
    England
    Administrateur
    PO BOX 112
    Canons Way
    BS99 7LB Bristol
    Canons House
    England
    England
    United KingdomBritish184348090003
    BUTLER, John Michael
    27 Headingley Mews
    St John's
    WF1 3AB Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    27 Headingley Mews
    St John's
    WF1 3AB Wakefield
    West Yorkshire
    British87985410004
    LAKIN, Helen Mary
    Gorphwysfa 6 Nant Road
    Bwlchgwyn
    LL11 5YN Wrexham
    Clwyd
    Secrétaire
    Gorphwysfa 6 Nant Road
    Bwlchgwyn
    LL11 5YN Wrexham
    Clwyd
    British41250190001
    MOORHOUSE, Robert Keith
    30 Rosehill Avenue
    Mosborough
    S20 5PP Sheffield
    Secrétaire
    30 Rosehill Avenue
    Mosborough
    S20 5PP Sheffield
    British57818440002
    NIXON, Raymond
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    British36433110016
    BLACK, Ian Spencer
    402 Birkby Road
    HD2 2DN Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    402 Birkby Road
    HD2 2DN Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish50474580001
    BUSH, Claude Harry
    51 Church Croft
    Dodleston
    CH4 9NT Chester
    Cheshire
    Administrateur
    51 Church Croft
    Dodleston
    CH4 9NT Chester
    Cheshire
    British427540002
    CARSON, James
    Shelley Drive
    Bothwell
    G71 8TA Glasgow
    88
    Administrateur
    Shelley Drive
    Bothwell
    G71 8TA Glasgow
    88
    British135127440001
    DADSON, Jacqueline Lesley
    16 Beech Grove
    Hoole
    CH2 3HJ Chester
    Administrateur
    16 Beech Grove
    Hoole
    CH2 3HJ Chester
    British31498940001
    DEVEY, Robert Alan
    16 Langcliffe Avenue
    HG2 8JQ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    16 Langcliffe Avenue
    HG2 8JQ Harrogate
    North Yorkshire
    UkBritish101508990001
    DONE, John Peter
    8 Llys Cadnant
    LL18 4DJ Rhyl
    Administrateur
    8 Llys Cadnant
    LL18 4DJ Rhyl
    British33202360001
    KIRKWOOD, Alan Ford
    5 Craiglockhart Loan
    EH14 1HU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Craiglockhart Loan
    EH14 1HU Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish116266980001
    LITTLER, Roy
    3 The Paddock
    Curzon Park
    CH4 8AE Chester
    Cheshire
    Administrateur
    3 The Paddock
    Curzon Park
    CH4 8AE Chester
    Cheshire
    British2211250001
    MEE, Robert James
    1 Feilden Court
    Mollington
    CH1 6LS Chester
    Administrateur
    1 Feilden Court
    Mollington
    CH1 6LS Chester
    EnglandBritish92913850001
    MERCER, John Alexander
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    Administrateur
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    British4672880001
    POSNER, Howard Michael
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    Administrateur
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    United KingdomBritish139631580001
    RAVENHILL, Nigel Patrick
    Overweather
    Plough Lane Chritleton
    CH3 7BA Chester
    Administrateur
    Overweather
    Plough Lane Chritleton
    CH3 7BA Chester
    British63827310001
    SHEARER, Christopher Allardice
    33d Maidencraig Crescent
    EH4 2BH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    33d Maidencraig Crescent
    EH4 2BH Edinburgh
    Midlothian
    British69741760001
    WARREN, Michael Ian
    137 Oakenshaw Lane
    Walton
    WF2 6NL Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    137 Oakenshaw Lane
    Walton
    WF2 6NL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish94336310002
    WOOLGROVE, Thomas
    Northwold
    Woodacre Crescent Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Northwold
    Woodacre Crescent Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    British103184580001
    HBOS DIRECTORS LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    73510890002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    EH1 1YZ Edinburgh
    The Mound
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    EH1 1YZ Edinburgh
    The Mound
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc327000
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge
    Créé le 19 juin 1996
    Livré le 10 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account or accounts in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 20 févr. 1995
    Livré le 22 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 13 déc. 1994
    Livré le 23 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 12 août 1993
    Livré le 20 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CAPITAL BANK INSURANCE SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 juin 2017Commencement of winding up
    17 avr. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0