NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02016098 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?
Adresse du siège social | Hatfields Thornton Road YO18 7JX Pickering North Yorkshire England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 janv. 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 oct. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 janv. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 15 avr. 2025 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 29 avr. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 15 avr. 2024 |
En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de John Sinclair Williams en tant que directeur le 19 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2024 | 18 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de Hatfields Calder Island Way Denby Dale Road Wakefield WF2 7AW à Hatfields Thornton Road Pickering North Yorkshire YO18 7JX le 24 juin 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2023 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2022 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 020160980010 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 020160980009 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 020160980008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Inscription de la charge 020160980011, créée le 22 avr. 2022 | 79 pages | MR01 | ||
Nomination de Mr Philip Richard Bennett en tant qu'administrateur le 14 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 janv. 2021 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2020 | 17 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Sinclair Williams le 20 mai 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth Sinclair Williams le 20 mai 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Justin Sinclair Williams le 20 mai 2020 | 1 pages | CH03 | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 janv. 2019 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 avr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 janv. 2018 | 16 pages | AA | ||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 2 pages | MR04 | ||
Qui sont les dirigeants de NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS, Justin Sinclair | Secrétaire | Thornton Road YO18 7JX Pickering Hatfields North Yorkshire England | British | Company Secretary | 21530100003 | |||||
BENNETT, Philip Richard | Administrateur | Thornton Road YO18 7JX Pickering Hatfields North Yorkshire England | England | British | Certified Accountant | 291836110001 | ||||
WILLIAMS, Gareth Sinclair | Administrateur | Thornton Road YO18 7JX Pickering Hatfields North Yorkshire England | England | British | Company Director | 51783610001 | ||||
WILLIAMS, Gareth Sinclair | Secrétaire | 41 South Downs Road Bowdon WA14 3HD Altrincham Cheshire | British | 51783610001 | ||||||
FLYNN, John Michael | Administrateur | The Cottage 2a Chatsworth Road PR8 2PQ Southport Merseyside | British | Accountant | 7770540001 | |||||
GATEHOUSE, David Stuart | Administrateur | Brockwell Heights Brockwell Lane Triangle Sowerby Bridge HX6 3PQ Halifax West Yorkshire | British | Motor Dealer | 7386020001 | |||||
WILLIAMS, John Sinclair | Administrateur | Thornton Road YO18 7JX Pickering Hatfields North Yorkshire England | England | British | Motor Vehicle Dealer | 7386030007 | ||||
WILLIAMS, Justin Sinclair | Administrateur | Roundhay Park Lane LS17 8AR Leeds Oakhill House England | England | British | Company Director | 21530100004 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr Gareth Sinclair Williams | 06 avr. 2016 | Thornton Road YO18 7JX Pickering Hatfields North Yorkshire England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
|
NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 22 avr. 2022 Livré le 26 avr. 2022 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 28 avr. 2017 Livré le 12 mai 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 28 avr. 2017 Livré le 12 mai 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 28 avr. 2017 Livré le 11 mai 2017 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 31 janv. 2002 Livré le 06 févr. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 26 mai 2000 Livré le 07 juin 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from mclean & appleton garages limited to the chargee on any account whatsoever provided that the total amount receoverable in relation thereto under this mortgage shall not exceed £3,000,000 | |
Brèves mentions The freehold property known as site E2 walton summit employment area bamber bridge preston lancashire title number LA595573. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment and charge of sub-leasing agreements | Créé le 16 mars 1998 Livré le 17 mars 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the assignment and charge | |
Brèves mentions All the rights title and interest of the company in sub leases in respect of equipment comprised in hp/leasing/contract hire agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A first fixed charge | Créé le 12 avr. 1996 Livré le 15 avr. 1996 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under hire purchase agreements or lease agreements | |
Brèves mentions All sub-lease agreements (the "sub-lease agreements") entered into at any time by the company with customers of the company relating to goods now or hereafter owned by the company but let by mbf to the company under hire purchase agreements or lease agreements (collectively "the credit agreements") entered into at any time between mbf and the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 24 mai 1991 Livré le 29 mai 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see form 395 and continuation sheet for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 08 sept. 1989 Livré le 18 sept. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 08 sept. 1989 Livré le 11 sept. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over all f/h and l/h property together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. uncalled capital stocks, shares and securities and goodwill floating charge over undertaking and all (other) property and assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0