NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED

NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02016098
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hatfields
    Thornton Road
    YO18 7JX Pickering
    North Yorkshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NORTH MANCHESTER CONTRACTS LIMITED04 janv. 198804 janv. 1988
    SUTTON & SON CONTRACTS (1986) LIMITED01 mai 198601 mai 1986

    Quels sont les derniers comptes de NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 janv. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 avr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 avr. 2024
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de John Sinclair Williams en tant que directeur le 19 août 2024

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2024

    18 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Hatfields Calder Island Way Denby Dale Road Wakefield WF2 7AW à Hatfields Thornton Road Pickering North Yorkshire YO18 7JX le 24 juin 2024

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2023

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2022

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 020160980010 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 020160980009 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 020160980008 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 020160980011, créée le 22 avr. 2022

    79 pagesMR01

    Nomination de Mr Philip Richard Bennett en tant qu'administrateur le 14 mars 2022

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2021

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2020

    17 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Sinclair Williams le 20 mai 2020

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth Sinclair Williams le 20 mai 2020

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Justin Sinclair Williams le 20 mai 2020

    1 pagesCH03

    Déclaration de confirmation établie le 14 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2019

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2018

    16 pagesAA

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, Justin Sinclair
    Thornton Road
    YO18 7JX Pickering
    Hatfields
    North Yorkshire
    England
    Secrétaire
    Thornton Road
    YO18 7JX Pickering
    Hatfields
    North Yorkshire
    England
    BritishCompany Secretary21530100003
    BENNETT, Philip Richard
    Thornton Road
    YO18 7JX Pickering
    Hatfields
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    Thornton Road
    YO18 7JX Pickering
    Hatfields
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritishCertified Accountant291836110001
    WILLIAMS, Gareth Sinclair
    Thornton Road
    YO18 7JX Pickering
    Hatfields
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    Thornton Road
    YO18 7JX Pickering
    Hatfields
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritishCompany Director51783610001
    WILLIAMS, Gareth Sinclair
    41 South Downs Road
    Bowdon
    WA14 3HD Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    41 South Downs Road
    Bowdon
    WA14 3HD Altrincham
    Cheshire
    British51783610001
    FLYNN, John Michael
    The Cottage
    2a Chatsworth Road
    PR8 2PQ Southport
    Merseyside
    Administrateur
    The Cottage
    2a Chatsworth Road
    PR8 2PQ Southport
    Merseyside
    BritishAccountant7770540001
    GATEHOUSE, David Stuart
    Brockwell Heights Brockwell Lane
    Triangle Sowerby Bridge
    HX6 3PQ Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Brockwell Heights Brockwell Lane
    Triangle Sowerby Bridge
    HX6 3PQ Halifax
    West Yorkshire
    BritishMotor Dealer7386020001
    WILLIAMS, John Sinclair
    Thornton Road
    YO18 7JX Pickering
    Hatfields
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    Thornton Road
    YO18 7JX Pickering
    Hatfields
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritishMotor Vehicle Dealer7386030007
    WILLIAMS, Justin Sinclair
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Oakhill House
    England
    Administrateur
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Oakhill House
    England
    EnglandBritishCompany Director21530100004

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Gareth Sinclair Williams
    Thornton Road
    YO18 7JX Pickering
    Hatfields
    North Yorkshire
    England
    06 avr. 2016
    Thornton Road
    YO18 7JX Pickering
    Hatfields
    North Yorkshire
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    NATIONWIDE MOTOR CONTRACTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 avr. 2022
    Livré le 26 avr. 2022
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 avr. 2017
    Livré le 12 mai 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 mai 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 avr. 2017
    Livré le 12 mai 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Fixed charges over all land and intellectual property owned by the company at any time.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 12 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 mai 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 avr. 2017
    Livré le 11 mai 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 11 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 mai 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 31 janv. 2002
    Livré le 06 févr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Gareth S. Williams, the Trustees of Jsw 1997 a & M Settlement, the Trustees of Gsw Life Interest Settlement and the Trustees of Justin Sw Lifeinterest Settlement (The "Lenders")
    Transactions
    • 06 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 26 mai 2000
    Livré le 07 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from mclean & appleton garages limited to the chargee on any account whatsoever provided that the total amount receoverable in relation thereto under this mortgage shall not exceed £3,000,000
    Brèves mentions
    The freehold property known as site E2 walton summit employment area bamber bridge preston lancashire title number LA595573. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Créé le 16 mars 1998
    Livré le 17 mars 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the assignment and charge
    Brèves mentions
    All the rights title and interest of the company in sub leases in respect of equipment comprised in hp/leasing/contract hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 17 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    A first fixed charge
    Créé le 12 avr. 1996
    Livré le 15 avr. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under hire purchase agreements or lease agreements
    Brèves mentions
    All sub-lease agreements (the "sub-lease agreements") entered into at any time by the company with customers of the company relating to goods now or hereafter owned by the company but let by mbf to the company under hire purchase agreements or lease agreements (collectively "the credit agreements") entered into at any time between mbf and the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mercedes-Benz Finance Limited
    Transactions
    • 15 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 24 mai 1991
    Livré le 29 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see form 395 and continuation sheet for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 29 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 04 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 sept. 1989
    Livré le 18 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 20 juil. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 sept. 1989
    Livré le 11 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all f/h and l/h property together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. uncalled capital stocks, shares and securities and goodwill floating charge over undertaking and all (other) property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0