COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED

COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02018783
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Patman House 23-27 Electric Parade George Lane
    E18 2LS London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GLORYTRENCH LIMITED12 mai 198612 mai 1986

    Quels sont les derniers comptes de COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 avr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2023

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Sarah Welby le 17 avr. 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nigel Frankell Welby le 08 mars 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Nicola Welby le 08 mars 2023

    1 pagesCH03

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    14 pagesAA

    Nomination de Ms Sarah Welby en tant qu'administrateur le 09 juil. 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de Mr Nigel Frankell Welby en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 janv. 2020

    2 pagesPSC04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michelle Warner le 29 janv. 2020

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Patman House 23-27B Electric Parade George Lane London E18 2LS England à Patman House 23-27 Electric Parade George Lane London E18 2LS le 29 janv. 2020

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David Christopher Phillips en tant que directeur le 10 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2017

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    15 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Richard Pearlman & Co 27 Phipp Street London EC2A 4NP à Patman House 23-27B Electric Parade George Lane London E18 2LS le 15 sept. 2017

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WELBY, Nicola
    George Lane
    E18 2LS London
    Patman House 23-27 Electric Parade
    United Kingdom
    Secrétaire
    George Lane
    E18 2LS London
    Patman House 23-27 Electric Parade
    United Kingdom
    British30103630001
    WARNER, Michelle Elaine
    George Lane
    E18 2LS London
    Patman House 23-27 Electric Parade
    United Kingdom
    Administrateur
    George Lane
    E18 2LS London
    Patman House 23-27 Electric Parade
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant125421680001
    WELBY, Nigel Frankell
    George Lane
    E18 2LS London
    Patman House 23-27 Electric Parade
    United Kingdom
    Administrateur
    George Lane
    E18 2LS London
    Patman House 23-27 Electric Parade
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director15386800004
    WELBY, Sarah
    George Lane
    E18 2LS London
    Patman House 23-27 Electric Parade
    United Kingdom
    Administrateur
    George Lane
    E18 2LS London
    Patman House 23-27 Electric Parade
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor285461770002
    CUFLEY, Sean Dominic Hardy
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant9150920001
    MILLER, David
    Chelsea House
    8-14 The Broadway
    RH163AP Haywards Heath
    C/O Commercial Management Limited
    England
    Administrateur
    Chelsea House
    8-14 The Broadway
    RH163AP Haywards Heath
    C/O Commercial Management Limited
    England
    EnglandBritishAccountant59650030006
    PHILLIPS, David Christopher
    Chelsea House
    8-14 The Broadway
    RH16 3AP Haywards Heath
    C/O Commercial Management Limited
    England
    Administrateur
    Chelsea House
    8-14 The Broadway
    RH16 3AP Haywards Heath
    C/O Commercial Management Limited
    England
    United KingdomBritishSurveyor41519710003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Nigel Frankell Welby
    Mill Lane
    South Chailey
    BN8 4PY Lewes
    Yokehurst Farm
    East Sussex
    England
    15 avr. 2017
    Mill Lane
    South Chailey
    BN8 4PY Lewes
    Yokehurst Farm
    East Sussex
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    COMMERCIAL MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of security assignment
    Créé le 28 janv. 2013
    Livré le 05 févr. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the chargor's present and future right title and interest in bsp and the benefit of all the chargor's present and future rights under the members agreement see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ingenious Resources Limited
    Transactions
    • 05 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of security assignment
    Créé le 24 déc. 2010
    Livré le 12 janv. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in big screen productions 16 LLP and the benefit of all future rights under the members agreement see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ingenious Resources Limited
    Transactions
    • 12 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    A charge over shares
    Créé le 27 mai 2005
    Livré le 02 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the securities and the derivative assets to the bank.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 02 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Charge of deposit
    Créé le 22 juil. 2003
    Livré le 30 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit initially of £1,646,437.89 credited to account designation 91020505 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 janv. 2001
    Livré le 30 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (as general partner of cml portfolio LP) to the chargee under a loan agreement dated 18TH january 2001 or under the legal charge
    Brèves mentions
    Various properties the first three of which are 75 high street barnstaple, 8 cornhill lincoln, 9-12 cornhill lincoln see form 395 for further details of property charged. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bradda Finance and Investment Limited
    Transactions
    • 30 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 janv. 2001
    Livré le 25 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the borrower's (as defined) liabilities to the chargee in any currency (whether present or future actual or contingent and whether alone od jointly with another) together with chargee's charges and commission interest and expenses
    Brèves mentions
    Properties k/a 75 high street barnstaple - DN193680; 8 conrhill lincoln - LL22400; 9-12 cornhill lincoln - LL25527 (see form M395 for further properties). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 08 janv. 1994
    Livré le 10 janv. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 22ND december 1993
    Brèves mentions
    All monies now or at ant time standing to the credit of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Union Bank of Finland LTD
    Transactions
    • 10 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0