ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED

ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASTEC COMMUNICATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02023193
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RANGENOW LIMITED28 mai 198628 mai 1986

    Quels sont les derniers comptes de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    État du capital au 10 mars 2021

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination de Mrs Janine Butler en tant qu'administrateur le 23 févr. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Nigel Evans en tant que directeur le 23 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2019

    9 pagesAA

    legacy

    256 pagesPARENT_ACC

    legacy

    2 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Nomination de Mr Andrew Michael Yorston en tant qu'administrateur le 02 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Diane Josephine Mcintyre en tant que directeur le 16 mars 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement2357692
    75473330004
    BUTLER, Janine
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish277534960001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish257275320001
    COTTLE, Paul
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    Secrétaire
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    British77894160002
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    HODGSON, Mark
    3 Cochran Close
    Churchdown
    GL3 2NA Gloucester
    Gloucestershire
    Secrétaire
    3 Cochran Close
    Churchdown
    GL3 2NA Gloucester
    Gloucestershire
    British72699060001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    WRIGHT, Garth Howard
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    British130769810001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BAMFORD, Peter Richard
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    Administrateur
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    British54076100002
    BARR, Robert Nicolas
    Lindfield Faringdon Road
    OX14 1BD Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    Lindfield Faringdon Road
    OX14 1BD Abingdon
    Oxfordshire
    UkBritish41968920003
    BEST, Pauline Ann
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    British68015830001
    BISWAS, Sumit Kumar
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    British63870460001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    COTTLE, Paul
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    Administrateur
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    British77894160002
    EDWARDS, Peter David
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    Administrateur
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    British1908570001
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    FREEMAN, William Ian Bede
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish64442870001
    GENT, Christopher Charles
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    British50867930001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Administrateur
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HARPER, Alan Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British27272400002
    HEXT, Jane Helen
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    Administrateur
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish152305810001
    HILLHOUSE, George Reid
    12 Churchview Drive
    Barnwood
    GL4 7ES Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    12 Churchview Drive
    Barnwood
    GL4 7ES Gloucester
    Gloucestershire
    British2899430001
    HODGSON, Mark
    2 Alcotts Green
    Sandhurst
    GL2 9PE Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    2 Alcotts Green
    Sandhurst
    GL2 9PE Gloucester
    Gloucestershire
    British72699060002
    KEAYS, Helen Margaret
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    British55393460002
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Administrateur
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MAXWELL, Ian Ronald
    Coach House Adbury Park
    Adbury
    RG15 8HB Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Coach House Adbury Park
    Adbury
    RG15 8HB Newbury
    Berkshire
    British16186890001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3381659
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of rent deposit
    Créé le 15 juil. 1996
    Livré le 16 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease dated 15TH july 1996
    Brèves mentions
    £10,868.75 or any increased sum payable into the deposit account in the name of the landlord at lloyds babk PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ravenseft Properties Limited
    Transactions
    • 16 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mars 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 08 juil. 1996
    Livré le 19 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of an underlease of even date
    Brèves mentions
    A rent deposit of £5,000 paid under a deed dated the 8/7/96. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ravenseft Properties Limited
    Transactions
    • 19 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mars 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 18 août 1995
    Livré le 05 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 12TH july 1995 and/or this deed
    Brèves mentions
    £11,163.50.
    Personnes ayant droit
    • The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty
    Transactions
    • 05 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mars 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 05 sept. 1994
    Livré le 10 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company`s right title and interest in and to the subscriber base al book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 05 sept. 1994
    Livré le 07 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two agreements dated 28/93 and 3/2/93 and/or this charge
    Brèves mentions
    The interest of the company in its customers from time to time as well as after as before any receiver may be appointed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Vodafone Limited
    Transactions
    • 07 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 sept. 1994
    Livré le 07 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Vodafone Group PLC
    Transactions
    • 07 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 06 févr. 1991
    Livré le 14 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements and/or this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Telecom Securicor Cellular Radiw Limited
    Transactions
    • 14 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 05 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 28 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 17 nov. 1986
    Livré le 26 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific charge over the benefit of all leasing rental hire purchase or credit sale agreements, all bills of exchange or promissory notes, all guarantees indemnities bonds or other securities. (For full details please see form 395 ref: M173/26NOV/ln).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 14 oct. 1986
    Livré le 22 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0