TV3 BROADCASTING GROUP LIMITED

TV3 BROADCASTING GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTV3 BROADCASTING GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02026891
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TV3 BROADCASTING GROUP LIMITED ?

    • Activités de programmation et de diffusion de télévision (60200) / Information et communication

    Où se situe TV3 BROADCASTING GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TV3 BROADCASTING GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SCANSAT BROADCASTING LIMITED07 juil. 198607 juil. 1986
    OBLONG WORKS LIMITED10 juin 198610 juin 1986

    Quels sont les derniers comptes de TV3 BROADCASTING GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TV3 BROADCASTING GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TV3 BROADCASTING GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 19 mai 2016

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Extinguishing of shares 06/05/2016
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 févr. 2016

    État du capital au 15 févr. 2016

    • Capital: GBP 7,738,600
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jonathan William Courtis Searle en tant que secrétaire le 02 juin 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Mathias Yong Nam Hermansson en tant que directeur le 15 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 janv. 2015

    État du capital au 23 janv. 2015

    • Capital: GBP 7,738,600
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mars 2014

    État du capital au 03 mars 2014

    • Capital: GBP 7,738,600
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 11 Chiswick Park 566 Chiswick High Road London W4 5XR* le 25 mars 2013

    1 pagesAD01

    Nomination de Dr Andreas Walker en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Marc Zagar en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Hans Albrecht en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de TV3 BROADCASTING GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WALKER, Andreas, Dr
    Chiswick High Road
    W4 5RU London
    610
    United Kingdom
    Administrateur
    Chiswick High Road
    W4 5RU London
    610
    United Kingdom
    United KingdomGerman175292940001
    BARNARD, Anne Trevenen
    37 Percy Road
    Shepherds Bush
    W12 9PX London
    Secrétaire
    37 Percy Road
    Shepherds Bush
    W12 9PX London
    British21643290001
    BESWICK, Timothy John
    77 Middle Mead
    RG27 9TE Hook
    Hampshire
    Secrétaire
    77 Middle Mead
    RG27 9TE Hook
    Hampshire
    British53577230001
    LINDBERG, Erik
    6 Bray Close
    Bray
    SL6 2BL Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    6 Bray Close
    Bray
    SL6 2BL Maidenhead
    Berkshire
    British55330960001
    LINDGREN, Johan Anders
    Osterangsvagen 24
    S-182 46 Enebyberg
    FOREIGN Sweden
    Secrétaire
    Osterangsvagen 24
    S-182 46 Enebyberg
    FOREIGN Sweden
    Swedish56775340001
    NILSSON, Reidar Yngve Alfons
    C/O Arkemar
    Wennerbergsgatan 2
    FOREIGN 112 58 Stockholm
    Sweden
    Secrétaire
    C/O Arkemar
    Wennerbergsgatan 2
    FOREIGN 112 58 Stockholm
    Sweden
    British75906300001
    SEARLE, Jonathan William Courtis
    Ormond Drive
    TW12 2TP Hampton
    39
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ormond Drive
    TW12 2TP Hampton
    39
    Middlesex
    United Kingdom
    British131420990001
    TORPE, Jens Johan
    Vallerod Banevej 30
    Dk-2960 Rungsted Kyst
    Denmark
    Secrétaire
    Vallerod Banevej 30
    Dk-2960 Rungsted Kyst
    Denmark
    Danish72763990001
    ZAGAR, Marc Andre
    36 Oxberry Avenue
    SW6 5SS London
    Secrétaire
    36 Oxberry Avenue
    SW6 5SS London
    French87438850002
    ABRAHAMSON, Lars Olof
    Kaptensbacken 10
    13334 Saltsjobaden
    FOREIGN Sweden
    Administrateur
    Kaptensbacken 10
    13334 Saltsjobaden
    FOREIGN Sweden
    Swedish57995760001
    ALBRECHT, Hans Holger
    Beverley Lane
    Loombe Hill
    KT2 7EE London
    Hans Place
    Kingston
    Administrateur
    Beverley Lane
    Loombe Hill
    KT2 7EE London
    Hans Place
    Kingston
    Gb-EngGerman136440710001
    BARRON, Andrew Mcgregor
    32 Glebe Road
    Barnes
    SW13 0EA London
    Administrateur
    32 Glebe Road
    Barnes
    SW13 0EA London
    United KingdomBritish93278790001
    BROWNE, John
    115 Ebury Street
    SW1W 9QU London
    Administrateur
    115 Ebury Street
    SW1W 9QU London
    British73632970002
    BRUNELL, Mia Christina
    Drabbningsvagen 5
    S-12530
    Alvsjo
    Sweden
    Administrateur
    Drabbningsvagen 5
    S-12530
    Alvsjo
    Sweden
    Swedish75905990001
    EJEMYR, Hans Christer
    Tantogatan 67
    S118 64 Stockholm
    Sweden
    Administrateur
    Tantogatan 67
    S118 64 Stockholm
    Sweden
    Swedish58921610001
    HERMANSSON, Mathias Yong Nam
    Karl Gerhards Vag 23
    Saltsjobaden
    Se-133 35
    Sweden
    Administrateur
    Karl Gerhards Vag 23
    Saltsjobaden
    Se-133 35
    Sweden
    SwedenSwedish113144820001
    JOHANNESSON, Daniel
    Industriforvltnings Ab Kinnevik
    Box 2094 S103 13 Stockholm
    FOREIGN
    Sweden
    Administrateur
    Industriforvltnings Ab Kinnevik
    Box 2094 S103 13 Stockholm
    FOREIGN
    Sweden
    Swedish21183250001
    LINDGREN, Johan Anders
    Osterangsvagen 24
    S-182 46 Enebyberg
    FOREIGN Sweden
    Administrateur
    Osterangsvagen 24
    S-182 46 Enebyberg
    FOREIGN Sweden
    Swedish56775340001
    NILSSON, Anders Karl Bo
    Birkagatan 26
    FOREIGN 11339 Stockholm
    Sweden
    Administrateur
    Birkagatan 26
    FOREIGN 11339 Stockholm
    Sweden
    Swedish75905740001
    NORDIN, Siig Goran
    Artillerigatan 28
    S-114 51
    Stockholm
    Sweden
    Administrateur
    Artillerigatan 28
    S-114 51
    Stockholm
    Sweden
    Swedish37056150001
    STEINMANN, Jan
    Trackways Chinnor Hill
    OX9 4BF Chinnor
    Oxfordshire
    Administrateur
    Trackways Chinnor Hill
    OX9 4BF Chinnor
    Oxfordshire
    Swedish48631550001
    STENBECK, Jan Hugo Robert Arne
    18 Rue Siggy
    L1933 Vu Letzenbuerg
    Luxembourg
    Administrateur
    18 Rue Siggy
    L1933 Vu Letzenbuerg
    Luxembourg
    Swedish74158500003
    SUNDSTROM, Mats
    10 Lanchester Road
    N6 4TA London
    Administrateur
    10 Lanchester Road
    N6 4TA London
    Swedish36416890001
    TANNEN, Michael Stephen
    90 Riverside Drive
    New York
    New York 1002y
    Usa
    Administrateur
    90 Riverside Drive
    New York
    New York 1002y
    Usa
    Us Citizen49518320001
    TORNBERG, Per Anders
    Bellmansgatan 8
    S-118 20
    Stockholm
    Sweden
    Administrateur
    Bellmansgatan 8
    S-118 20
    Stockholm
    Sweden
    Swedish36172490002
    WISSEN, Bjorn Ake Magnus
    333 East 68 Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Administrateur
    333 East 68 Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Swedish49330460001
    ZAGAR, Marc Andre
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XR London
    11
    Administrateur
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XR London
    11
    United KingdomFrench131421670002

    TV3 BROADCASTING GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 janv. 1995
    Livré le 03 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to S.G. warburg & co limited -as agent and trustee for itself and the banks ,as defined- under or pursuant to the terms of the finance documents -as defined - and or this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • S.G. Warburg & Co. Limited.
    • `
    Transactions
    • 03 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit agreement
    Créé le 29 juin 1992
    Livré le 07 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights to the repayment of the deposit all interest (a/c no 7167670) for full details refer to doc M395 ref M831C).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 juin 1992
    Livré le 09 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and as arranger for the banks (as defined)
    Brèves mentions
    See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • S.G.Warburg & Co LTD
    Transactions
    • 09 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Counter-indeminity
    Créé le 05 févr. 1990
    Livré le 14 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    £150,000 standing to the credit of a designated account with the bank designated lloyds bank PLC "re scan sat broadcasting LTD".
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 14 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 02 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0