PROPERTY SEARCH AGENCY LIMITED

PROPERTY SEARCH AGENCY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPROPERTY SEARCH AGENCY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02027265
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PROPERTY SEARCH AGENCY LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PROPERTY SEARCH AGENCY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5-7 Abbey Court Eagle Way
    Sowton Industrial Estate
    EX2 7HY Exeter
    Devon
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PROPERTY SEARCH AGENCY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GRANDGUIDE LIMITED11 juin 198611 juin 1986

    Quels sont les derniers comptes de PROPERTY SEARCH AGENCY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour PROPERTY SEARCH AGENCY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Mark Francis Milner en tant que directeur le 05 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 nov. 2015

    État du capital au 30 nov. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Carl Martin en tant que directeur le 30 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 5 Fleet Place London EC4M 7rd à 5-7 Abbey Court Eagle Way Sowton Industrial Estate Exeter Devon EX2 7HY le 30 juil. 2015

    2 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014

    7 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2014 au 30 sept. 2014

    1 pagesAA01

    Nomination de David William Callcott en tant que secrétaire le 31 janv. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Robin Pimenta en tant que secrétaire le 31 janv. 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr David William Callcott en tant qu'administrateur le 31 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robin Pimenta en tant que directeur le 31 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark Francis Milner en tant qu'administrateur le 31 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 déc. 2014

    État du capital au 19 déc. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 nov. 2013

    État du capital au 29 nov. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Richard John Hinton en tant que directeur le 30 avr. 2013

    1 pagesTM01

    Nomination de Carl Martin en tant qu'administrateur le 30 avr. 2013

    2 pagesAP01

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Stuart David Pearce en tant que directeur le 05 oct. 2012

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de PROPERTY SEARCH AGENCY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CALLCOTT, David William
    5-7 Abbey Court
    Eagle Way, Sowton
    EX2 7HY Exeter
    Landmark Information Group
    Devon
    United Kingdom
    Secrétaire
    5-7 Abbey Court
    Eagle Way, Sowton
    EX2 7HY Exeter
    Landmark Information Group
    Devon
    United Kingdom
    195005580001
    CALLCOTT, David William
    5-7 Abbey Court
    Eagle Way, Sowton
    EX2 7HY Exeter
    Landmark Information Group
    Devon
    United Kingdom
    Administrateur
    5-7 Abbey Court
    Eagle Way, Sowton
    EX2 7HY Exeter
    Landmark Information Group
    Devon
    United Kingdom
    EnglandBritish85543390001
    DUNNE, Simon Daniel
    18a St Peters Street
    N1 8JW London
    Secrétaire
    18a St Peters Street
    N1 8JW London
    British5146920001
    PENNEY, David Anthony Stephen
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4AJ West Maling
    42
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4AJ West Maling
    42
    Kent
    United Kingdom
    British25814340002
    PIMENTA, Robin
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Secrétaire
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    158834930001
    RIDDICK, Mark
    Highbank House
    Mill Hill Lane
    DA12 3HA Shorne
    Kent
    Secrétaire
    Highbank House
    Mill Hill Lane
    DA12 3HA Shorne
    Kent
    British5146910001
    DUNNE, Simon Daniel
    18a St Peters Street
    N1 8JW London
    Administrateur
    18a St Peters Street
    N1 8JW London
    British5146920001
    HINTON, Richard John
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    United KingdomBritish91353630001
    LLOYD, Andrew Stuart
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    EnglandBritish106610300001
    MARTIN, Carl
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish177936250001
    MILNER, Mark Francis
    5-7 Abbey Court
    Eagle Way, Sowton
    EX2 7HY Exeter
    Landmark Information Group
    Devon
    United Kingdom
    Administrateur
    5-7 Abbey Court
    Eagle Way, Sowton
    EX2 7HY Exeter
    Landmark Information Group
    Devon
    United Kingdom
    EnglandBritish174048810001
    PEARCE, Stuart David
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    EnglandBritish134479250001
    PENNEY, David Anthony Stephen
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4AJ West Maling
    42
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4AJ West Maling
    42
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish25814340002
    PIMENTA, Robin Luke, Mr.
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    Administrateur
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    England
    EnglandBritish196075550001
    RIDDICK, Lisa Patricia
    High Bank House
    Mill Hill Lane Shorne
    DA12 3HA Gravesend
    Kent
    Administrateur
    High Bank House
    Mill Hill Lane Shorne
    DA12 3HA Gravesend
    Kent
    EnglandBritish56303490001
    RIDDICK, Mark
    Highbank House
    Mill Hill Lane
    DA12 3HA Shorne
    Kent
    Administrateur
    Highbank House
    Mill Hill Lane
    DA12 3HA Shorne
    Kent
    United KingdomBritish5146910001
    SOMMERVILLE, Andrew James
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4AJ West Maling
    42
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4AJ West Maling
    42
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish25814350004

    PROPERTY SEARCH AGENCY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 27 mai 2005
    Livré le 04 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 04 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 29 mai 2003
    Livré le 06 juin 2003
    En cours
    Montant garanti
    Six thousand two hundred and sixteen pounds and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    A rent deposit of £6,216 plus vat. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Enodis Investments Limited
    Transactions
    • 06 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 10 mai 2000
    Livré le 15 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 22 juin 1999
    Livré le 30 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or search matters limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 oct. 1987
    Livré le 31 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    100, white lion street london N1 &/or the proceed of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 02 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0