RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02029313 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1st Floor Randstad Court Laporte Way LU4 8SB Luton Bedfordshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
État du capital au 22 sept. 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 13 déc. 2013
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christiana Adeola Bernard en tant que directeur le 28 mars 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 19 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Joseph Deamer en tant que directeur le 31 janv. 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 20 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Rod Jackson en tant que directeur le 06 janv. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Joost Carel Sandor Gietelink en tant qu'administrateur le 19 déc. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Colin Graham Reader en tant que directeur le 19 déc. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 20 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Jonathon Bull le 30 août 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Nomination de Mark Jonathon Bull en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Brian Wilkinson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1st Floor Regent Court Laporte Way Luton Beds LU4 8SB United Kingdom le 01 juil. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Naylor en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULL, Mark Jonathan | Administrateur | Randstad Court Laporte Way LU4 8SB Luton 1st Floor Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 89717310001 | |||||
| GIETELINK, Joost Carel Sandor | Administrateur | Upper Walk Virginia Park GU25 4SN Virginia Water 4 Surrey United Kingdom | United Kingdom | Netherlands | 164363820001 | |||||
| BELCHEM, Gary | Secrétaire | 17 Turkey Oak Close Upper Norwood SE19 2NZ London | British | 66391670002 | ||||||
| HALE, Derrick Bernard | Secrétaire | Dorchester Court Dexter Close AL1 5WD St Albans 35 Herts | British | 132647080001 | ||||||
| HIRD, John Charles | Secrétaire | 6 Ardshiel Close SW15 1EB London | British | 9558850001 | ||||||
| HORN, Alan David | Secrétaire | 70 The Grove MK40 3JN Bedford | British | 47516350001 | ||||||
| MEPANI, Daksha | Secrétaire | 46a Howberry Road HA8 6SY Edgware Middlesex | British | 76052010001 | ||||||
| NAYLOR, Ian | Secrétaire | Oakhill Road TN13 1NU Sevenoaks 77 Kent United Kingdom | 147428880001 | |||||||
| NEWTON-CLARE, Herbert Mitchell | Secrétaire | Fallowfield Hightown BH24 3HE Ringwood Hampshire | British | 9558860002 | ||||||
| WOOD, Michael Napier Vout | Secrétaire | 5 Townsend Leys NN10 8LW Higham Ferrers Northamptonshire | British | 79379490001 | ||||||
| BEHAN, Christopher George Vincent | Administrateur | Hill Cottage The Green Brill HP18 9RU Aylesbury Buckinghamshire | British | 62369030001 | ||||||
| BERNARD, Christiana Adeola | Administrateur | Green Lane AL3 6EU St. Albans Sycamore Lodge 158 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 135725020001 | |||||
| DEAMER, Kevin Joseph | Administrateur | Richmond Close Frimley GU16 8NR Camberley 18 Surrey United Kingdom | England | British | 5734140001 | |||||
| HICKMORE, Angela Genevieve | Administrateur | 32 Holly Grove PO16 7UP Fareham Hampshire | England | British | 74194550002 | |||||
| HIRD, John Charles | Administrateur | 6 Ardshiel Close SW15 1EB London | British | 9558850001 | ||||||
| HOLMAN, Michael Lawrence | Administrateur | Greensands Brassey Road Limpsfield RH8 0EU Oxted Surrey | British | 15211120001 | ||||||
| HORN, Alan David | Administrateur | 70 The Grove MK40 3JN Bedford | England | British | 47516350001 | |||||
| IRWIN, Terence Christopher | Administrateur | 12 Brentcot Close W13 8EH London Greater London | United Kingdom | British | 100714610001 | |||||
| JACKSON, Rod | Administrateur | The Pound Hawstead IP29 5NJ Bury St. Edmunds Joffaca House Suffolk United Kingdom | England | Uk | 98229300002 | |||||
| MARTIN, Anthony Victor | Administrateur | Aston Court Aston Hill HP22 5NQ Halton Buckinghamshire | United Kingdom | British | 6123340003 | |||||
| MILES, Charles Kenneth Zachary | Administrateur | 18 Lansdowne Road TN1 2NJ Tunbridge Wells Kent | British | 39243410001 | ||||||
| NEWTON-CLARE, Herbert Mitchell | Administrateur | Fallowfield Hightown BH24 3HE Ringwood Hampshire | British | 9558860002 | ||||||
| READER, Colin Graham | Administrateur | 51 Arlington Road NW1 7ES London | United Kingdom | British | 3037660001 | |||||
| ROWLEY, John | Administrateur | Hickling Lodge Melton Road LE14 3QG Hickling Pastures Leicestershire | England | British | 11900790002 | |||||
| SUGDEN, Richard Paul | Administrateur | 12 The Slype Gustard Wood Wheathampstead AL4 8RY St Albans Hertfordshire | British | 49273690001 | ||||||
| WALKER, Roger Arthur | Administrateur | Conigree Dock Lane, Bredon GL20 7LG Tewkesbury Gloucestershire | United Kingdom | British | 63790980002 | |||||
| WILKINSON, Brian | Administrateur | The Old Mistal Newsholme Oakworth BD22 0QT Keighley West Yorkshire | United Kingdom | British | 11900780002 |
RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 02 mai 1996 Livré le 09 mai 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0