LAMMERMUIR LEASING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LAMMERMUIR LEASING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02033887 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LAMMERMUIR LEASING LIMITED ?
| Adresse du siège social | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LAMMERMUIR LEASING LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour LAMMERMUIR LEASING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 4 pages | 4.71 | ||||||||||
Dépôt d'insolvabilité Insolvency:secretary of state's release of liquidator | 1 pages | LIQ MISC | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Ordonnance du tribunal d'insolvabilité Court order INSOLVENCY:court order - removal/ replacement of liquidator | 30 pages | LIQ MISC OC | ||||||||||
Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire | 1 pages | 4.40 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB à 15 Canada Square London E14 5GL le 11 avr. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 14 mars 2016
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Adam Paul Rutherford en tant que secrétaire le 14 août 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2014 | 11 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Chris Snailham en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Divers Section 519 | 3 pages | MISC | ||||||||||
Divers S.519 compant act 2006 | 2 pages | MISC | ||||||||||
Divers Section 519 | 2 pages | MISC | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Kenyon Thomas le 24 févr. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2013 | 11 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LAMMERMUIR LEASING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGSHAW, Joanne Louise | Secrétaire | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | 180380420001 | |||||||
| BARTLETT, Andrew William | Secrétaire | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 73852930003 | ||||||
| SNAILHAM, Christopher Charles | Administrateur | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British | 202149290001 | |||||
| THOMAS, David Kenyon | Administrateur | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House England England | United Kingdom | British | 59397060006 | |||||
| BURTON, Jennifer Sandra | Secrétaire | 39b Butler Avenue HA1 4EJ West Harrow Middlesex | British | 100622570001 | ||||||
| RUFFELL, Lara Catherine | Secrétaire | 23 Meadowlands Chineham RG24 8XL Basingstoke Hampshire | British | 69140140002 | ||||||
| RUTHERFORD, Adam Paul | Secrétaire | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 70451850004 | ||||||
| SHOOLBRED, Charles Frederick | Secrétaire | Timbers Dean Oak Lane RH2 8PZ Leigh Surrey | British | 540290002 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Secrétaire | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 49004930001 | |||||||
| BOOBYER, Christopher Leslie Richard | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 92233050001 | ||||||
| BOX, Sarah | Administrateur | Court Lodge Lower Road West Farleigh ME15 0PD Maidstone Kent | British | 47381630004 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Administrateur | Fairway Heights GU15 1NJ Camberley 14 Surrey | United Kingdom | British | 2444200001 | |||||
| CLARK, Thomas Martin | Administrateur | Hatch Hill Hatch Lane Kingsley Green GU27 3LJ Haslemere Surrey | British | 5529800001 | ||||||
| DOWDING, Eric Robert | Administrateur | 23 Waldorf Heights Blackwater Howley Hill GU17 9JH Camberley Surrey | British | 46728970001 | ||||||
| ELLIS, David James | Administrateur | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | 113760650001 | |||||
| GOLDSBROUGH, Christopher Andrew John | Administrateur | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British/New Zealand | 153832500002 | |||||
| HOYLE, Stephen Lewis | Administrateur | 2 Haslemere Road N8 9QX London | United Kingdom | British | 96838010001 | |||||
| LEATHER, Jonathan Terence | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 69140360003 | ||||||
| LEWIS, Barry Randall | Administrateur | 37 Main Road Littleton SO22 6QJ Winchester Hampshire | England | British | 145163830001 | |||||
| MACFARLANE, Stuart Edward | Administrateur | 6 Lynmouth Road East Finchley N2 9LS London | Australian | 125721120002 | ||||||
| MACINTOSH, Gordon Paterson | Administrateur | 7 Paddock Field Chilbolton SO20 6AU Stockbridge Hampshire | British | 25737780001 | ||||||
| MCGIDDY, Mark Andrew | Administrateur | Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House 1 | Australian | 114990900003 | ||||||
| MCMILLAN, Richard John | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 68601920002 | ||||||
| MILLINER, Craig | Administrateur | 21 Smithson Close Talbot Village BH12 5EY Poole Dorset | British | 144700710001 | ||||||
| PRESS, Matthew | Administrateur | 106 Ledbury Road W11 2AH London | Australian | 104610910001 | ||||||
| ROWAN, Charles Paul | Administrateur | 32 Queens Park West Drive Queens Park BH8 9DD Bournemouth Dorset | British | 49237910001 | ||||||
| ROWBERRY, Duncan John | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 49237880003 | ||||||
| SILCOCK, Frank Avis | Administrateur | Charleston 74 Wellhouse Road Beech GU34 4AG Alton Hampshire | British | 32895910001 | ||||||
| SIVANITHY, Rajanbabu | Administrateur | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | United Kingdom | British | 63268810003 | |||||
| THOMPSON, Peter Gordon | Administrateur | 8 Wagtail Walk Langley Park BR3 3XG Beckenham Kent | British | 61570160003 | ||||||
| VASUDEVA, Nicholas Shashi | Administrateur | 57 Linden Gardens W2 4HJ London Flat 1 | British/Australian | 79508880002 | ||||||
| WEAL, Barry | Administrateur | Orchard Gate Mill Lane Bramley GU5 0HW Guildford Surrey | British | 40203100001 | ||||||
| WEAVING, John Martin | Administrateur | 57 Bridle Way Colehill BH21 2UP Wimborne Dorset | British | 58523120001 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 49004930001 | |||||||
| BAROMETERS LIMITED | Administrateur | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 57357300002 |
LAMMERMUIR LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Créé le 30 déc. 1992 Livré le 13 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due from i/s danwheel and/or svend arvad jensen to the bank under the terms of the loan agreement dated 30/12/92 | |
Brèves mentions All right title & interest in & to the assigned payments & all sums paid or payable in respect thereof (for full details refer to doc M395 & continuation sheets). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Sublessee security agreement | Créé le 30 déc. 1992 Livré le 14 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti The performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargees under the terms of the sublease dated 24/11/92 & from the company under the terms of the head lease dated 24/11/92 | |
Brèves mentions All the grantors right title & interest as lessee in the head lease & as secured party in the head security agreement (for full details refer to doc M395 & continuation sheets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
LAMMERMUIR LEASING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0