BEDFORDSHIRE CHAMBER OF TRAINING

BEDFORDSHIRE CHAMBER OF TRAINING

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBEDFORDSHIRE CHAMBER OF TRAINING
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société 02035299
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BEDFORDSHIRE CHAMBER OF TRAINING ?

    • Enseignement secondaire technique et professionnel (85320) / Enseignement

    Où se situe BEDFORDSHIRE CHAMBER OF TRAINING ?

    Adresse du siège social
    The Business Competitiveness
    Centre, Kimpton Road
    LU2 0SX Luton
    Bedfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BEDFORDSHIRE CHAMBER OF TRAINING ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour BEDFORDSHIRE CHAMBER OF TRAINING ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de David Murray Eales en tant que directeur le 21 mars 2013

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Viviane Marie Paule Vayssieres en tant que directeur le 03 oct. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Brian Edward Hibbert en tant que directeur le 03 oct. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Judith Elizabeth Oliver en tant que directeur le 03 oct. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lawrence Frederick Davies en tant que directeur le 03 oct. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juil. 2012 sans liste des membres

    11 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juil. 2011 sans liste des membres

    11 pagesAR01

    Nomination de Mr David Ellinor en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    11 pagesAA

    Nomination de Mr Jeremy Neil Brockis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Graham Mcmullen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juil. 2010 sans liste des membres

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Stephen Coates en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Rodney John Calvert en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    11 pagesAA

    Nomination de Ms Viviane Marie Paule Vayssieres en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Graham John Mcmullen en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Lacy en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    11 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BEDFORDSHIRE CHAMBER OF TRAINING ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RICHARDSON, Justin Roger
    9 Brook View
    Grange Park
    NN4 5DR Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    9 Brook View
    Grange Park
    NN4 5DR Northampton
    Northamptonshire
    British101016920001
    BROCKIS, Jeremy Neil
    The Business Competitiveness
    Centre, Kimpton Road
    LU2 0SX Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Business Competitiveness
    Centre, Kimpton Road
    LU2 0SX Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritishSolicitor142191560001
    CALVERT, Rodney John
    The Business Competitiveness
    Centre, Kimpton Road
    LU2 0SX Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Business Competitiveness
    Centre, Kimpton Road
    LU2 0SX Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritishConsultant65812620001
    ELLINOR, David Robert
    The Business Competitiveness
    Centre, Kimpton Road
    LU2 0SX Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Business Competitiveness
    Centre, Kimpton Road
    LU2 0SX Luton
    Bedfordshire
    United KingdomBritishCommercial Banking Director54832450001
    RENTON, Elliot Paul
    23 St Mary's Avenue
    N3 1SN London
    Administrateur
    23 St Mary's Avenue
    N3 1SN London
    United KingdomBritishAccountant127257890001
    STEWART, Pauline Ann
    52 Asgard Drive
    Cranbourne Gardens
    MK41 0US Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    52 Asgard Drive
    Cranbourne Gardens
    MK41 0US Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritishManaging Director93621470003
    HOSKINS, Philip A
    The Old Rectory
    Campton
    SG17 5PF Shefford
    Beds
    Secrétaire
    The Old Rectory
    Campton
    SG17 5PF Shefford
    Beds
    British15562520001
    MULVANERTY, Noel Vincent
    7 Hollies Walk
    Wootton
    MK43 9LB Bedford
    Bedfordshire
    Secrétaire
    7 Hollies Walk
    Wootton
    MK43 9LB Bedford
    Bedfordshire
    BritishFinance Controller64517830001
    SMYTHE, Joanne
    1 Mill Cottage
    Bridge Street
    MK43 8ER Turvey
    Bedfordshire
    Secrétaire
    1 Mill Cottage
    Bridge Street
    MK43 8ER Turvey
    Bedfordshire
    British80512510002
    WEE, Stephen
    17 Tibbett Close
    LU6 3TT Dunstable
    Bedfordshire
    Secrétaire
    17 Tibbett Close
    LU6 3TT Dunstable
    Bedfordshire
    BritishAssociate Director Finance73684580001
    WHITE, Nicholas John
    8 High Street
    Souldrop
    MK44 1EY Bedford
    Bedfordshire
    Secrétaire
    8 High Street
    Souldrop
    MK44 1EY Bedford
    Bedfordshire
    British65139630001
    ANDERSON, Gordon Mcdonald
    3 Guessens Road
    AL8 6QW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Guessens Road
    AL8 6QW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishBank Official78556390001
    ARNOLD, Thomas Edward
    April Rise
    11 Rotten Row
    MK44 1EJ Riseley
    Bedfordshire
    Administrateur
    April Rise
    11 Rotten Row
    MK44 1EJ Riseley
    Bedfordshire
    BritishManaging Director67992960001
    ASHDOWN, Nigel Stanley
    303 Norton Way South
    SG6 1SU Letchworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    303 Norton Way South
    SG6 1SU Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishBusiness Consultant2554530001
    BAGGOTT, David Richard
    4 Chantry Close
    Woburn Sands
    MK17 8UB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    4 Chantry Close
    Woburn Sands
    MK17 8UB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishSolicitor61564350002
    BAGGOTT, Joseph Harold Singleton
    Hillcroft
    Mortimer Hill
    HP23 5JA Tring
    Herts
    Administrateur
    Hillcroft
    Mortimer Hill
    HP23 5JA Tring
    Herts
    BritishRetired Company Director28045490001
    BORTHWICK, Clive Oliver
    33 Rothamsted Avenue
    AL5 2DN Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    33 Rothamsted Avenue
    AL5 2DN Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor39280570001
    BROWN, David Ian
    14 Meadow Green
    AL8 6SS Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Meadow Green
    AL8 6SS Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritishPrincipal College Corporation34864680001
    BUCK, Ethel
    Elm Farm Keysoe Row East
    Keysoe
    MK44 2JB Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    Elm Farm Keysoe Row East
    Keysoe
    MK44 2JB Bedford
    Bedfordshire
    BritishBusiness Consultant37809580001
    BURNIP, Anthony Roger
    Lilac Cottage 63 Newport Road
    Woburn Sands
    MK17 8UQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Lilac Cottage 63 Newport Road
    Woburn Sands
    MK17 8UQ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDir Motor Vehicle Manufacturer18783570001
    CALVERT, Rodney John
    Sails Cottage 7 Windmill Hill
    Biddenham
    MK40 4AG Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    Sails Cottage 7 Windmill Hill
    Biddenham
    MK40 4AG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishManaging Director65812620001
    CHENNELLS, William James
    65 West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    65 West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    BritishSolicitor14630010001
    CLARK, Kenneth Robert
    13 Lodge Road
    NN10 9HA Rushden
    Northamptonshire
    Administrateur
    13 Lodge Road
    NN10 9HA Rushden
    Northamptonshire
    BritishRecruitment Consultant7815040001
    CLARK, Stephen Robert
    114 Hillesden Avenue
    Elstow
    MK42 9AJ Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    114 Hillesden Avenue
    Elstow
    MK42 9AJ Bedford
    Bedfordshire
    BritishManaging Director60851690002
    CLATWORTHY, Stuart Charles
    Holly Cottage
    Clophill Road, Maulden
    MK45 2AE Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    Holly Cottage
    Clophill Road, Maulden
    MK45 2AE Bedford
    Bedfordshire
    BritishEngineer16319940001
    COATES, Stephen William
    Duck End
    Silver Road
    MK43 7QW Stevington
    Bedfordshire
    Administrateur
    Duck End
    Silver Road
    MK43 7QW Stevington
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director18043650003
    COLEMAN, Paul
    Maudeleyns Barn
    Marlin Chapel Farm
    HP4 3UQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Maudeleyns Barn
    Marlin Chapel Farm
    HP4 3UQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishBusiness Councellor79805620001
    COLLOP, Spencer John
    10 Ulverston Road
    LU6 3QE Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    10 Ulverston Road
    LU6 3QE Dunstable
    Bedfordshire
    BritishDirector8298470001
    COMBES, Richard George
    The Grange Church Road
    Westoning
    MK45 5JW Bedford
    Administrateur
    The Grange Church Road
    Westoning
    MK45 5JW Bedford
    United KingdomBritishChartered Accountant39280640001
    COMBES, Richard George
    The Grange Church Road
    Westoning
    MK45 5JW Bedford
    Administrateur
    The Grange Church Road
    Westoning
    MK45 5JW Bedford
    United KingdomBritishChartered Accountant39280640001
    COWAN, Peter John
    Casablanca Wild Cherry Drive
    LU1 3UH Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    Casablanca Wild Cherry Drive
    LU1 3UH Luton
    Bedfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant1815800001
    DAVIES, Lawrence Frederick
    29 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    29 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishPurchasing Director73002440001
    DE LA SALLE, Brian John
    5 Beech Ridge Kinsbourne Green Lane
    AL5 3NS Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Beech Ridge Kinsbourne Green Lane
    AL5 3NS Harpenden
    Hertfordshire
    BritishSelf Employed28514140002
    DIVER, Kenneth Edward Frederick
    37 Ludlow Avenue
    LU1 3RW Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    37 Ludlow Avenue
    LU1 3RW Luton
    Bedfordshire
    BritishFlooring Contractor2611690001
    DUNHAM, Charles Gerald John
    41 The Paddocks
    Linslade
    LU7 7SX Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    41 The Paddocks
    Linslade
    LU7 7SX Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishDirector Motor Retailer9570080001

    BEDFORDSHIRE CHAMBER OF TRAINING a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge
    Créé le 12 mai 1994
    Livré le 18 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the chamber of commerce and industry for bedfordshire and district to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge (as defined)
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0