BRITSHIP APRIL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRITSHIP APRIL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02036822
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRITSHIP APRIL LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe BRITSHIP APRIL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRITSHIP APRIL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    A&L CF DECEMBER (8) LIMITED16 nov. 200416 nov. 2004
    SOVEREIGN CAR LEASING LIMITED14 juil. 198614 juil. 1986

    Quels sont les derniers comptes de BRITSHIP APRIL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour BRITSHIP APRIL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    13 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 oct. 2010

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de Maersk House Braham Street London E1 8EP le 21 oct. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 août 2010

    État du capital au 16 août 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de James Burridge en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Martyn Clive Allen en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    15 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Modification des coordonnées du secrétaire John Kilby le 22 déc. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Kilby le 22 déc. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    14 pagesAA

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de BRITSHIP APRIL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KILBY, John, Mr.
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Secrétaire
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    British76247880001
    ALLEN, Martyn Clive
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Administrateur
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    United KingdomBritish117739980001
    KILBY, John, Mr.
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Administrateur
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    EnglandBritish76247880001
    DUVAL, Michael John
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    British72879690001
    HEPPLEWHITE, Julian
    The Old Rectory
    Rectory End
    LE8 9EW Burton Overy
    Leicestershire
    Secrétaire
    The Old Rectory
    Rectory End
    LE8 9EW Burton Overy
    Leicestershire
    British51619950002
    SINCLAIR FORD, Ian Andrew
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    Secrétaire
    Stainton 103 Menlove Avenue
    Calderstones
    L18 3HP Liverpool
    British58189030001
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Secrétaire
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    British27312630001
    BRITTAIN, Frederick Humphrey
    C/O Sovereign Leasing Plc
    298 Deansgate
    M3 4HH Manchester
    Gtr Manchester
    Administrateur
    C/O Sovereign Leasing Plc
    298 Deansgate
    M3 4HH Manchester
    Gtr Manchester
    British23574940002
    BURRIDGE, James George Thomas
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    Administrateur
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    EnglandUnited Kingdom59355820001
    DUFFY, Anthony Paul
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    Administrateur
    7 Outram Road
    Alexandra Park
    N22 7AB London
    EnglandBritish72286750001
    DUVAL, Michael John
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Greenfields
    Ponds Road
    CM2 8QP Chelmsford
    Essex
    British72879690001
    EVANS, Martin William
    26 Moss Lane
    Bramhall
    SK7 1EH Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    26 Moss Lane
    Bramhall
    SK7 1EH Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish55210060002
    GUGGLBERGER, Klaus
    Graf Starhembergasse 4
    1040 Vienna
    Austria
    Administrateur
    Graf Starhembergasse 4
    1040 Vienna
    Austria
    Austrian32780800002
    JARDINE, John
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    Administrateur
    The Old School Guilden Sutton Lane
    Guilden Sutton
    CH3 7EX Chester
    British31897840002
    LEE, Andrew Philip, Mr.
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    Administrateur
    29 Alder Lane
    Balsall Common
    CV7 7DZ Solihull
    United KingdomBritish73882180001
    MALONE, Mark
    Evans Drift
    Kesgrave
    IP5 2BD Ipswich
    4
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Evans Drift
    Kesgrave
    IP5 2BD Ipswich
    4
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish138898280001
    MARKS, Norman
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    Administrateur
    4 Old Hall Park
    Guilden Sutton
    CH3 7ER Chester
    British48820520002
    MOORE, Susan Jennifer
    11 Quayside Court
    Abbotshade Road
    SE16 5RG London
    Administrateur
    11 Quayside Court
    Abbotshade Road
    SE16 5RG London
    British99501960001
    MORLEY, Colin Richard
    Flat 1 Model Lodging House
    Bloom Street
    M3 6AJ Salford
    Lancashire
    Administrateur
    Flat 1 Model Lodging House
    Bloom Street
    M3 6AJ Salford
    Lancashire
    EnglandBritish89102840002
    SCOTT, Ian Garden
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Riverbank House
    AB34 5JD Aboyne
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish79132120001
    STONE, Philip
    37 Blackmead
    TN13 2QU Riverhead
    Kent
    Administrateur
    37 Blackmead
    TN13 2QU Riverhead
    Kent
    British104108420001
    SWANN, Andrew Blyth
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Nield House
    Beamond End
    HP7 0QT Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish60626890003
    TAYLOR, Charles Stuart
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    Administrateur
    Balnacroft 8 Stonewalls
    Rosemary Lane Rossett
    LL12 0LG Wrexham
    Flintshire
    United KingdomBritish27312630001
    TOWERS, Robert Leslie
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    Administrateur
    27 Winwick Park Avenue
    Winwick
    WA2 8XB Warrington
    United KingdomBritish65275200002
    WHITE, Charles Toby Fitzherbert
    Hopton Wafers
    DY14 0NA Cleobury Mortimer
    The Manor House
    Shropshire
    Administrateur
    Hopton Wafers
    DY14 0NA Cleobury Mortimer
    The Manor House
    Shropshire
    United KingdomUk129100360001

    BRITSHIP APRIL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A first priority ship mortgage
    Créé le 22 déc. 2004
    Livré le 11 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the company's right, title and interest in the 4,300 teu container vessel named (glasgow maersk) under official number 902672 and includes any share or interest therein and her engines, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, spare gear, belongings and appurtenances;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Maersk Company Limited
    Transactions
    • 11 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A first priority ship mortgage
    Créé le 22 déc. 2004
    Livré le 11 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the company's right, title and interest in the 4,300 teu container vessel named (greenwich maersk) under official number 902673 and includes any share or interest therein and her engines, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, spare gear, belongings and appurtenances;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Maersk Company Limited
    Transactions
    • 11 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An accounts assignment
    Créé le 22 déc. 2004
    Livré le 29 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right title and interest, present and future, in and to: each of the dollar and sterling proceeds accounts numbered 11058460 and number 11058487, the moneys, interest and amounts on such accounts.
    Personnes ayant droit
    • The Maersk Company Limited
    Transactions
    • 29 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of covenant
    Créé le 22 déc. 2004
    Livré le 29 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the right, title and interest, present and future, to and in the "ship" meaning the 4,300 teu container vessel named "glasgow maersk" under official number 902672 and her engines, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, spare gear, belongings and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Maersk Company Limited
    Transactions
    • 29 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of covenant
    Créé le 22 déc. 2004
    Livré le 29 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the right, title and interest, present and future, to and in the "ship" meaning the 4,300 teu container vessel named "greenwich maersk" under official number 902673 and her engines, machinery, boats, tackle, outfit, equipment, spare gear, belongings and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Maersk Company Limited
    Transactions
    • 29 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An accounts assignment
    Créé le 22 déc. 2004
    Livré le 29 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right title and interest, present and future, in and to: each of the dollar and sterling proceeds accounts numbered 11058452 and number 11058479, the moneys, interest and amounts on such accounts.
    Personnes ayant droit
    • The Maersk Company Limited
    Transactions
    • 29 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    BRITSHIP APRIL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 oct. 2010Commencement of winding up
    17 août 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0