COFFEE POINT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOFFEE POINT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02037135
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COFFEE POINT LIMITED ?

    • Autres services de restauration (56290) / Hébergement et restauration

    Où se situe COFFEE POINT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    East Wing 14th Floor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COFFEE POINT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CRAYGLOW LIMITED15 juil. 198615 juil. 1986

    Quels sont les derniers comptes de COFFEE POINT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour COFFEE POINT LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour COFFEE POINT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 mars 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 févr. 2015

    État du capital au 20 févr. 2015

    • Capital: GBP 100,941
    SH01

    Nomination de Mr Kris Paul Ludo Geysels en tant qu'administrateur le 18 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Brian Mackie en tant que directeur le 18 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 mars 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 févr. 2014

    État du capital au 04 févr. 2014

    • Capital: GBP 100,941
    SH01

    Nomination de Mr Daniel Henry Abrahams en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Helen Willis en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Brian Mackie le 01 mai 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Cessation de la nomination de War Tin en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de War Tin en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Deuxième dépôt de AP01 précédemment soumis à Companies House

    5 pagesRP04
    Annotations
    DateAnnotation
    10 janv. 2013A second filed AP01 was registered for Helen Willis

    Deuxième dépôt de TM01 précédemment soumis à Companies House

    4 pagesRP04
    Annotations
    DateAnnotation
    07 janv. 2013Second filed TM01 for Timothy Roe

    Comptes pour une société dormante établis au 01 avr. 2012

    7 pagesAA

    Nomination de Mrs War War Tin en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Michael Greenwood en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Helen Margaret Willis en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    10 janv. 2013A second filed AP01 was registered on the 10 January 2012

    Qui sont les dirigeants de COFFEE POINT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ABRAHAMS, Daniel Henry
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    EnglandBritish183822370001
    GEYSELS, Kris Paul Ludo
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    BelgiumBelgian193655140001
    COOK, Josephine Isabel
    White House
    Clinton Lane
    TN8 7PP Bough Beech
    Secrétaire
    White House
    Clinton Lane
    TN8 7PP Bough Beech
    British66475960002
    GREENWOOD, Michael Frank
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Secrétaire
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    British163171710001
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Secrétaire
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    British28010290009
    TIN, War War
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Secrétaire
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    174470180001
    BROTHERWOOD, Tony James
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    Administrateur
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    EnglandBritish143546010001
    CUNNINGHAM, James Alan
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    Administrateur
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    EnglandBritish51864840002
    DEMBITZ, John Andrew
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    Administrateur
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    British15837270001
    DEMBITZ, John Andrew
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    Administrateur
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    British15837270001
    DOBBS, Neil Stoker
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    Administrateur
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    United KingdomBritish20511010001
    DRYSDALE, Harold Bruce
    6 Windsor Park
    NE28 8UQ Wallsend
    Tyne & Wear
    Administrateur
    6 Windsor Park
    NE28 8UQ Wallsend
    Tyne & Wear
    British111822640001
    DRYSDALE, Harold Bruce
    Field House
    Eachwick
    NE18 0AY Newcastle
    Administrateur
    Field House
    Eachwick
    NE18 0AY Newcastle
    United KingdomBritish106272340001
    HUGHES, Leonard
    50 St Margarets Street
    ME1 1TU Rochester
    Kent
    Administrateur
    50 St Margarets Street
    ME1 1TU Rochester
    Kent
    British52234370002
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    EnglandBritish28010290009
    LEWIS, Gary Kenneth
    89 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    Administrateur
    89 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    United KingdomBritish65266510002
    MACKIE, Brian
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    ScotlandBritish173446760002
    MOONEY, Andrew John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish34345860002
    MURRELL, Andrew John
    5 Wood Ride
    BR5 1PZ Petts Wood
    Kent
    Administrateur
    5 Wood Ride
    BR5 1PZ Petts Wood
    Kent
    EnglandBritish114514100001
    NAISMITH, Nicholas John Ewen
    Grants
    Grants Lane
    RH8 0RQ Limpsfield
    Surrey
    Administrateur
    Grants
    Grants Lane
    RH8 0RQ Limpsfield
    Surrey
    British2892470011
    NEWBERRY, Charles Timothy
    56 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    Administrateur
    56 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    EnglandEnglish29754260005
    PRATT, Isabelle
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    French103007770001
    PRATT, Isabelle
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    French103007770001
    ROE, Timothy Michael
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritish51264250001
    STRINGFELLOW, Robin John
    23a The Street
    Corton
    NR32 5HW Lowestoft
    Suffolk
    Administrateur
    23a The Street
    Corton
    NR32 5HW Lowestoft
    Suffolk
    British113787560001
    THOMPSON, Peter Charles Fenton
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    Administrateur
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    British19655110001
    THOMPSON, Peter Charles Fenton
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    Administrateur
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    British19655110001
    TRACE, Charles Lawrence
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish129244340001
    TRACE, Charles Lawrence
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    Administrateur
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    EnglandBritish129244340001
    WHITELING, Mark Argent
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritish101297630001
    WILLIS, Helen Margaret
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    United KingdomBritish277089380001

    COFFEE POINT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Master assignment
    Créé le 16 nov. 2005
    Livré le 29 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All monies due and the benefit of all guarantees, indemnities, negotiable instruments and securities in connection with the assigned agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Universal Leasing Limited
    Transactions
    • 29 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over shares
    Créé le 05 mars 2004
    Livré le 12 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The shares and security assets and includes any proceeds of sale or other realisation thereof or any part thereof, shares 14,940 ordinary shares in the share capital of sk automatics limited (no. 1394004).
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 12 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 11 févr. 2003
    Livré le 19 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares and security assets and any proceeds of sale or other realisation thereof and all stocks,securities,rights,money or other property and bonus,dividend and interest accruing thereon.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 févr. 2003
    Livré le 14 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 14 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 11 févr. 2003
    Livré le 13 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 13 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 janv. 2002
    Livré le 08 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 24 june 1991 issued by the company
    Créé le 26 juin 2000
    Livré le 30 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 4 may 1995 between confidential invoice discounting limited and the company and any deed amending or replacing the same (all such deeds being hereinafter called the charged deeds) and all book debts and other debts the subject of the charged deeds as and when the same shall become due or owing to the company upon re-vesting in the company whether pursuant to the charged deeds or otherwise.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 sept. 1999
    Livré le 30 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 30 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 juin 1991
    Livré le 03 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 10 nov. 1988
    Livré le 17 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 17 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    • 09 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 09 août 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    COFFEE POINT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 mars 2015Commencement of winding up
    22 mars 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0