EXCHANGE HOUSE HOLDINGS LIMITED

EXCHANGE HOUSE HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEXCHANGE HOUSE HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02037407
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EXCHANGE HOUSE HOLDINGS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe EXCHANGE HOUSE HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EXCHANGE HOUSE HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROSEHAUGH STANHOPE (BROADGATE PHASE 11) PLC29 oct. 198629 oct. 1986
    ALPHAFORM (NO. FIFTEEN) PUBLIC LIMITED COMPANY15 juil. 198615 juil. 1986

    Quels sont les derniers comptes de EXCHANGE HOUSE HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour EXCHANGE HOUSE HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2022 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    État du capital au 08 déc. 2022

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Jonathan David Lovejoy en tant que directeur le 28 nov. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Jonathan David Lovejoy en tant qu'administrateur le 18 mars 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sarah Morrell Barzycki en tant que directeur le 18 mars 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Jonathan David Taylor en tant qu'administrateur le 18 mars 2022

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    4 pagesAA

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nigel Mark Webb le 04 juil. 2019

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Timothy Andrew Roberts en tant que directeur le 31 mars 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de EXCHANGE HOUSE HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement8992198
    187856670001
    TAYLOR, Jonathan David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive294038720001
    WEBB, Nigel Mark
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishHead Of Developments58059360001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secrétaire
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    British1898090001
    HALLAM, Jonathan Paul
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    Secrétaire
    11 Trinity Road
    SW19 8QT London
    British36631180001
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    MORKEL, Alan Gaunson
    Bramble Cottage 1 Churn Lane
    Horsmonden
    TN12 8HL Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    Bramble Cottage 1 Churn Lane
    Horsmonden
    TN12 8HL Tonbridge
    Kent
    British2068470001
    PENRICE, Victoria Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    190034190001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Administrateur
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishCompany Director2068480001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant166550001
    BLACKBURN, David Michael
    Lansdowne Road
    W11 3AL London
    7
    Administrateur
    Lansdowne Road
    W11 3AL London
    7
    EnglandBritishDirector Of Companies67601540001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Administrateur
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRADMAN, Godfrey Michael
    15 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Administrateur
    15 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    BritishChairman & Chief Executive2068500001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Administrateur
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    CAMP, David John
    11 Walham Grove
    SW6 London
    Administrateur
    11 Walham Grove
    SW6 London
    BritishNew Business Director4807190002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    DANTZIC, Roy Matthew
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Administrateur
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    BritishFinancial Director52294450003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Surveyor1188110001
    KERSHAW, Peter
    34 Esher Park Avenue
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    Administrateur
    34 Esher Park Avenue
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    BritishDirector Of Companies51322410001
    LIPTON, Stuart Anthony, Sir
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    Administrateur
    40 Queens Grove
    NW8 6HH London
    EnglandBritishDirector Of Companies2068540001
    LOVEJOY, Jonathan David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor262176650001
    MANNION, Michael John Francis
    32 Acacia Way
    The Hollies
    DA15 8WW Sidcup
    Kent
    Administrateur
    32 Acacia Way
    The Hollies
    DA15 8WW Sidcup
    Kent
    United KingdomBritishCivil Engineer57126040001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    PENRICE, Victoria Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary189931090001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Administrateur
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman & Md Brit. Land Co./41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    RIVLIN, Paul Denis
    42 Rochester Road
    NW1 9JJ London
    Administrateur
    42 Rochester Road
    NW1 9JJ London
    BritishDirector Of Companies2068550001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EXCHANGE HOUSE HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bl Retail Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 avr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement5995033
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    EXCHANGE HOUSE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A composite supplemental trust deed
    Créé le 29 août 2006
    Livré le 13 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the british land company PLC as issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Euston tower regent's place euston road london t/no NGL797170. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited (The Trustee)
    Transactions
    • 13 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Twelfth supplemental trust deed (the "twelfth supplemental trust deed") made between the british land company PLC ("british land") certain of its subsidiaries (including the company) and royal exchange trust company limited (the "trustee") supplemental to the trust deed dated 6TH october 1995 (the "principal trust deed")
    Créé le 30 avr. 2001
    Livré le 11 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The totalamount payable under the trust deeds namely the principal of premium (if any) and interest on the bonds and on all (if any) further bonds (as defined) which may be created and issued by british land and constituted and secured by a trust deed and all other monies due or to become due from the company to the chargee intended to be secured by or payable under or pursuant to the trust deeds or any future trust deed supplemental to the principal trust deed
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in the property together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited as Trustee for the Holders of the Bonds
    Transactions
    • 11 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Ninth supplemental trust deed made between (inter alia)the british land company PLC ("the issuer") the company and the trustee (as defined) supplemental to the trust deed dated 6TH october 1995 (the "principal trust deed")
    Créé le 23 août 1999
    Livré le 27 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The total amount payable under the trust deeds referred to above, namely the principal of, and interest on the £250,000,000 8 7/8 per cent. First mortgage debenture bonds 2035 of the issuer, all further bonds (as defined in the principal trust deed) whether or not of the same series and all other monies payable by the issuer to the trustee under the terms of the said trust deeds and any trust deeds supplemental thereto.
    Brèves mentions
    Land and buildings on the north side of oxford road banbury t/no: ON176441 all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery all existing leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited (The "Trustee")
    Transactions
    • 27 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 sept. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 06 juil. 1994
    Acquis le 01 juil. 1994
    Livré le 06 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The estate and interest of the company under the head lease ,being all the land and premises and airspace adjoining primrose street ,and appold street, london EC2, please see doc for further details,.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1994Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 06 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 juil. 1994
    Acquis le 01 juil. 1994
    Livré le 05 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC,
    Transactions
    • 05 juil. 1994Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 06 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge.
    Créé le 05 juil. 1994
    Acquis le 01 juil. 1994
    Livré le 05 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the estate and interest of the chargor under the head lease -as defined) the land premises and airspace situated adjoining primrose street and appold street, london EC2,and comprising the property known as exchange house,primrose street, london, please see doc for further details,.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 juil. 1994Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 06 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 05 juil. 1994
    Acquis le 01 juil. 1994
    Livré le 05 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that leasehold property known as or being exchange house , primrose street,london EC2 ,(formerly known as PHASE11 broadgate, ).
    Personnes ayant droit
    • Railtrack PLC
    Transactions
    • 05 juil. 1994Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 09 déc. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 01 juil. 1994
    Livré le 13 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC(,as agent and trustee for the banks -as defined) supplemental to the terms of a loan agreement dated 23RD december 1988,an agreement dated 31ST march 1989,the override agreement (as defined) and/or this charge.
    Brèves mentions
    The benefit of account number 00602248 at national westminster bank PLC ,natwest markets, group treasury settlements, 200 pentonville road, london N1 9HL, (sort code 70-01-19)in the name of the company, being the rental account, please see doc for further details,.
    Personnes ayant droit
    • National Westminter Bank PLC,
    Transactions
    • 13 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 15 juil. 1993
    Livré le 16 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to county natwest limited, as agent and trustee for the banks (as defined), under or pursuant to the loan agreement dated 23RD december 1988 as varied by the override agreement dated 23RD november 1992 and otherwise as identified in the charge
    Brèves mentions
    Each and every interest rate hedging agreement from time to time and all monies.........the benefit of acct/no.00602302........see form 395.
    Personnes ayant droit
    • County Natwest Limitedas Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 16 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Group debenture
    Créé le 23 nov. 1992
    Livré le 01 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "override agreement" dated 23RD november 1992 and this charge
    Brèves mentions
    See doc ref M103 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 23 nov. 1992
    Livré le 25 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 23.12.88 (as defined)
    Brèves mentions
    The benefit of the hedging agreement.............all monies from time to time........benefit of acct/no.66626601. See form 395.
    Personnes ayant droit
    • County Natwest Limitedas Agent and Trustee for the Banks
    Transactions
    • 25 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 12 janv. 1989
    Livré le 16 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks in any manner under or pursuant to the loan agreement dated 23/12/88 and/or this charge.
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all the estate and interest of the company under the headlease in the land premises and airspace situated adjoining primrose street and appold street partly in the city of london and partly in l/borough of hackney (please see doc for full details).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 janv. 1989
    Livré le 13 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement of even date.
    Brèves mentions
    L/H property k/a phase 11 broadgate london EC2.
    Personnes ayant droit
    • British Railways Board Hamilton House
    Transactions
    • 13 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 09 déc. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0