RUBY DCO TEN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRUBY DCO TEN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02040018
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RUBY DCO TEN LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe RUBY DCO TEN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Office 5, International House
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RUBY DCO TEN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MEDIMART LIMITED23 juil. 198623 juil. 1986

    Quels sont les derniers comptes de RUBY DCO TEN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour RUBY DCO TEN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de Admenta Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023

    1 pagesPSC07

    Notification de Dunamis Mind Accelerator Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023

    2 pagesPSC02

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re: change of name / company shall be entitled to appoint a sole director / such director shall have the authority to exercise all powers and discretions of the directors confered by the articles 31/08/2023
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Nomination de Thorsten Sprank en tant qu'administrateur le 31 août 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Graham Wiseman en tant que directeur le 31 août 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Dominik Muser en tant que directeur le 31 août 2023

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Sapphire Court Walsgrave Triangle Coventry CV2 2TX à Office 5, International House Cray Avenue Orpington BR5 3RS le 04 sept. 2023

    1 pagesAD01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed medimart LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 sept. 2023

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    État du capital après une attribution d'actions au 29 août 2023

    • Capital: GBP 630,001
    3 pagesSH01

    État du capital au 29 août 2023

    • Capital: GBP 0.0001
    5 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share premium 29/08/2023
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Nomination de Mr Dominik Muser en tant qu'administrateur le 06 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 25 janv. 2023 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    3 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    Re-removal of restriction on authorised shares capital 07/09/2022
    RES13
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    33 pagesMA

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    2 pagesSH10

    Cessation de la nomination de Wendy Margaret Hall en tant que directeur le 09 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nichola Louise Legg en tant que secrétaire le 09 sept. 2022

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de RUBY DCO TEN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SPRANK, Thorsten
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Administrateur
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandGerman203900280002
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secrétaire
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Secrétaire
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Secrétaire
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    LEGG, Nichola Louise
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Secrétaire
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    163214890001
    MURPHY, Francis Joseph
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    Secrétaire
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    British32866430003
    ROCHE, Colleen Elisabeth
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    British35456530001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Secrétaire
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    TWAROWSKI, Maria Elizabeth
    11 Spinners Chase
    Pudsey
    LS28 7BB Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    11 Spinners Chase
    Pudsey
    LS28 7BB Leeds
    West Yorkshire
    British47378310001
    BARCLAY, Raymond Dunbar
    23 Cheviot Close
    Wash Common
    RG14 6SQ Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    23 Cheviot Close
    Wash Common
    RG14 6SQ Newbury
    Berkshire
    British44192900001
    BEER, Thorsten
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Administrateur
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman172030260001
    BURGAN, Lynne Frances
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish3311690001
    BURGAN, Philip John
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish2140090001
    ENGLAND, Philip Nicholas
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    Administrateur
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    British43835770003
    HALL, Wendy Margaret
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Administrateur
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish172979860001
    HILGER, Marcus
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Administrateur
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    GermanyGerman238936580003
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Administrateur
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    KEEN, Christian
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Administrateur
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish54544790004
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Administrateur
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    LIPP, Hanns Martin
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Administrateur
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman220582440001
    MAJOR, Michael Evelyn
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    Administrateur
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    British31230890001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Administrateur
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    MUSER, Dominik
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Administrateur
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    GermanyGerman295759150001
    PRIDMORE, Richard
    62 Tinshill Road
    Cookridge
    LS16 7DS Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    62 Tinshill Road
    Cookridge
    LS16 7DS Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish39535850001
    ROCHE, Colleen Elisabeth
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    British35456530001
    ROCHE, Patrick Joseph
    Penny Gate
    Swindon Lane Kirkby Overblow
    HG3 1HH Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Penny Gate
    Swindon Lane Kirkby Overblow
    HG3 1HH Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish126410600001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    STEWART, Brian
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish980530001
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British122881190001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    WISEMAN, Graham
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Administrateur
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandBritish299860960001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RUBY DCO TEN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Dunamis Mind Accelerator Limited
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    31 août 2023
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    06 avr. 2016
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementGreat Britain
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement244282
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    RUBY DCO TEN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 17 oct. 1994
    Livré le 18 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H-goldwick pharmacy glodwick health centre goldwick road, oldham including all guarantees and covenats now or in the future subsisting in respect of the property and the benefit of all insurance policies all moneys and proceeds paid or payable inrespect of the property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 18 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juil. 1994
    Livré le 30 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Brèves mentions
    F/H-459 great horton road bradford west yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 30 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 juin 1994
    Livré le 18 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First charge on all stock shares bonds and securities of any kind whatsoever including all dividends interest or other distributions in respect of the same and all allotments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 18 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 juin 1994
    Livré le 18 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Brèves mentions
    L/H-ground floor premises 280-282 lees road oldham lancs. Floating charge over all tha moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 18 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 mai 1994
    Livré le 25 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H-34 nostell place bessacarr doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 25 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 mai 1994
    Livré le 25 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H-the pharmacy sinclair house woodside view the crescent woodlands doncster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 25 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 mai 1994
    Livré le 25 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H-2 princess street woodlands doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 25 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 mai 1994
    Livré le 25 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H- the pharmacy land and buildings on the east side of adwick road mexborough doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 25 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 mai 1994
    Livré le 20 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H-6 york bar york road doncaster. All moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 20 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 03 mai 1994
    Livré le 09 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H-the pharmacy new street dinnington rotherham south yorkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 09 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 04 mars 1994
    Livré le 14 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-pharmacy at the new health centre cluntergate horbury wakefield west yorkshire t/n-WYK542628, WTK459121 and WYK55116 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 1994
    Livré le 04 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan and/or this charge
    Brèves mentions
    First fixed charge on all stocks shares bonds and securities of any kind whatsoever including all dividends interest or other distributions paid or payable or made in respect of the same and allotments accreations offers rights benefits and advantages on all stocks shares rights money or property accruing or offered at any time by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 04 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 janv. 1994
    Livré le 01 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan and/or this mortgage
    Brèves mentions
    L/H-48 cheapside barnsley south yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 01 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 janv. 1994
    Livré le 26 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan and/or under the terms of the debenture and security
    Brèves mentions
    L/H-3A far lane wadsley and land on the south side of wadsley lane and land on the N.E. of far lane sheffield t/n-SYK210526 and SYK313104. All moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture by way of floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 26 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 déc. 1993
    Livré le 18 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or aah pharmaceuticals limited to the chargee under the terms of a loan and/or this mortgage
    Brèves mentions
    L/H-the pharmacy minden centre st.johns garden the rock bury t/n-GM633326. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finanace Limited
    Transactions
    • 18 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 13 déc. 1993
    Livré le 18 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or aah pharmaceuticals limited to the chargee under the terms of a loan and/or this charge
    Brèves mentions
    L/H-unit 3 ribblesdale house market street bury t/n-GM512146. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finanace Limited
    Transactions
    • 18 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 sept. 1993
    Livré le 14 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee
    Brèves mentions
    F/H-86 burgoyne road sheffield t/n-SYK113360. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 14 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 juil. 1993
    Livré le 07 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal mortgage
    Brèves mentions
    L/H-13 halifax road dewsbury west yorkshire and stock-in-trade. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 07 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 juin 1993
    Livré le 07 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-50-52 high street idle bradford west yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 07 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 01 avr. 1993
    Livré le 06 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-property hereinafter described and the proceeds of sale thereof together with a at any time placed upon or used in or about the property and an assignment of the goodwill and connection of any business or businesses from time to time carried on in or upon the property or any part or parts thereof together with the full benefit of all licences including any registrations viz: 21 and 21A chapeltown pudsey leeds west yorkshire t/n-WYK24687. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 avr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 01 mars 1993
    Livré le 08 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (For full details see form 395 and contd sheets attached). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 08 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 févr. 1993
    Livré le 04 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 04 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 sept. 1992
    Livré le 07 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H-26 main street garforth leeds west yorshire (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 07 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 juin 1992
    Livré le 05 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 05 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 avr. 1992
    Livré le 22 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (For full details of property see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Statim Finance Limited
    Transactions
    • 22 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0