STAGECOACH WEST LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTAGECOACH WEST LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02041677
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STAGECOACH WEST LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe STAGECOACH WEST LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Daw Bank
    Stockport
    SK3 0DU Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STAGECOACH WEST LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WESTERN TRAVEL LIMITED20 oct. 198620 oct. 1986
    EXPELOAK LIMITED29 juil. 198629 juil. 1986

    Quels sont les derniers comptes de STAGECOACH WEST LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour STAGECOACH WEST LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mai 2013

    État du capital au 07 mai 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Leslie Brian Warneford en tant que directeur le 26 avr. 2013

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 04 mars 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Ian Roy Manning en tant que directeur le 21 févr. 2013

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2011

    14 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    7 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2010

    14 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Roy Manning le 11 mai 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael John Vaux le 10 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2009

    13 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Leslie Brian Warneford le 01 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Colin Brown le 15 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael John Vaux le 07 oct. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de STAGECOACH WEST LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    DAVISON, Jeremy Robert
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    Secrétaire
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    British65096740001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Secrétaire
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    British70283550001
    HEMMING, Christopher Thomas
    Bankura Stoke Road
    Bishops Cleeve
    GL52 7RT Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Bankura Stoke Road
    Bishops Cleeve
    GL52 7RT Cheltenham
    Gloucestershire
    British17902220001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Secrétaire
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    British45931770001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Secrétaire
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    CARTER, Alex Paul
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    British41601830001
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Administrateur
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    British47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    British70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Administrateur
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritish1436830002
    DAVISON, Jeremy Robert
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    Administrateur
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    British65096740001
    DYER, Andrew William
    10 Saxholm Way
    SO16 7GU Southampton
    Administrateur
    10 Saxholm Way
    SO16 7GU Southampton
    British62948690001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Administrateur
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritish70283550001
    GLOAG, Ann Heron
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    Administrateur
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish141120003
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Administrateur
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish61722690002
    HILDITCH, Christopher Graham
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    British10417870001
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Administrateur
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritish2268190002
    HIRON, William
    10 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    10 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British15390480001
    IRVING, Charles, Sir
    The Grange
    GL50 2JH Cheltenham
    Glos
    Administrateur
    The Grange
    GL50 2JH Cheltenham
    Glos
    British31938710001
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish58643710001
    LYON, Inglis
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    British72280120001
    MANNING, Ian Roy
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish90558800001
    RHYS-DAVIES, Mark Iorwedd
    10 Evesham Road
    GL52 2AB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    10 Evesham Road
    GL52 2AB Cheltenham
    Gloucestershire
    British5652350001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Administrateur
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritish73518280001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Administrateur
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    British1436810001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Administrateur
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    United KingdomBritish45931770001
    STOCKLEY, Philip John
    Flat 31 Sirocco
    33 Channel Way
    SO14 3JE Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Flat 31 Sirocco
    33 Channel Way
    SO14 3JE Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish125533810001
    SUTTON, Martin
    44 Chandos Street
    Winchcombe
    GL54 5HX Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    44 Chandos Street
    Winchcombe
    GL54 5HX Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish54001710002
    THOMAS, Mark Richard
    The Quarry House
    Upper Lynch Road France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Quarry House
    Upper Lynch Road France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    British28914510001
    THOMAS, Norrie Russell
    Catherine Cottage Silver Street
    Chalford Hill
    GL6 8ES Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Catherine Cottage Silver Street
    Chalford Hill
    GL6 8ES Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritish1447710001
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish49771140004
    WHITE, Robert Neil Pratt
    18 Celandine Court
    Ty Canol
    NP44 6JU Cwmbran
    Gwent
    Administrateur
    18 Celandine Court
    Ty Canol
    NP44 6JU Cwmbran
    Gwent
    British20722660001
    WILLIAMS, Paul Raymond
    Lane House
    Quarry Place
    SY1 1JN Shrewsbury
    Salop
    Administrateur
    Lane House
    Quarry Place
    SY1 1JN Shrewsbury
    Salop
    United KingdomBritish8407960003

    STAGECOACH WEST LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 30 sept. 1996
    Livré le 12 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and under the agreement and under any of the other finance documents and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without prejudice to the foregoing generality, all obligations to indemnify the chargee (the "secured liabilities") provided that the expression secured liabilites shall not include any relevant liabilities of the company
    Brèves mentions
    (1) as security for the payment of all secured liabilities, the chargor with full title guarantee charges in favour of the chargee for itself and as agent and security trustee aforesaid by way of floating charge all its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandfor Itself and as Agent and Security Trustee for and on Behalf of the Banks, the Issuing Bank and the Overdraft Bank
    Transactions
    • 12 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 10 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot at gloucester road lansdown ind est cheltenham gloucs, all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 10 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot canal road cwmbach aberdare mid glamorgan all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 10 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot lake road brynmawr gwent all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 10 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot risca road crosskeys newport gwent all buildings and other structures, any goodwill, plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 10 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot somerset road st. David's road cwmbran gwent, all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 10 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot unit 20 merthyr tydfil ind est dowlais merthyr tydfil mid glamorgan, all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery etc, floating charge all unattached plant machinery chattels goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 02 févr. 1996
    Livré le 17 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and under any of the other finance documents and/or any deed or document supplemental thereto
    Brèves mentions
    By way of floating charge all its undertaking property assets and rights present and future.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandfor Itself and as Security Trustee for and on Behalf of the Banks the Issuing Bank and the Overdraft Bank
    Transactions
    • 17 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 02 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot at eastcott road swindon wilts.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 02 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot at station approach leamington spa warwickshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 02 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot at new town road warwickshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 02 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot at railway terrace rugby warwickshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 02 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot at london road gloucester.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 02 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises at london road bowbridge stroud gloucestershire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1995
    Livré le 02 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus depot at canal street banbury oxfordshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 déc. 1993
    Livré le 18 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as western travel limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 avr. 1992
    Livré le 12 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Please see doc M436C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 oct. 1986
    Livré le 10 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a share purchase agreement of even date.
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Bus Company
    Transactions
    • 10 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 31 oct. 1986
    Livré le 07 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Charge by way of specific equitable charge over all estates and/or interest of f/h & l/h property flowing charge over over taking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. (For full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transactions
    • 07 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 21 déc. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0