UCI EXHIBITION (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéUCI EXHIBITION (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02045911
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de UCI EXHIBITION (UK) LIMITED ?

    • Activités de projection de films cinématographiques (59140) / Information et communication

    Où se situe UCI EXHIBITION (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de UCI EXHIBITION (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CIC12 janv. 198912 janv. 1989
    AMC EXHIBITION (UK) LIMITED03 déc. 198603 déc. 1986
    DIKAPPA (NUMBER 444) LIMITED12 août 198612 août 1986

    Quels sont les derniers comptes de UCI EXHIBITION (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour UCI EXHIBITION (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX à 1 More London Place London SE1 2AF le 08 nov. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 11 oct. 2017

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 19 sept. 2017

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Craig Ray Ramsey en tant que directeur le 13 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Brooks Rainer en tant qu'administrateur le 06 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kirsten Lawton en tant que secrétaire le 12 juil. 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Andrew Stephen Alker en tant que directeur le 06 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neil James Williams en tant que directeur le 06 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Jonathan Way en tant que directeur le 06 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Craig Ray Ramsey en tant qu'administrateur le 06 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Michael Donovan en tant que directeur le 30 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de UCI EXHIBITION (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RAINER, John Brooks
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United StatesAmericanTax Acountant230136900001
    FOX, Carol Collins
    Lee House
    90 Greay Bridgewater Street
    M1 5JW Manchester
    Secrétaire
    Lee House
    90 Greay Bridgewater Street
    M1 5JW Manchester
    British34028170003
    JAGANNATH, Vidya
    4 Caterham Avenue
    BL3 3RF Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    4 Caterham Avenue
    BL3 3RF Bolton
    Lancashire
    British104920640001
    LAWTON, Kirsten
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    Secrétaire
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    BritishChartered Secretary50045660003
    MCDONAGH, John James
    6 Redesmere Close
    Timperley
    WA15 7EE Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    6 Redesmere Close
    Timperley
    WA15 7EE Altrincham
    Cheshire
    British38769610001
    RIBBONS, Justin Charles
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    Secrétaire
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    British23745010013
    RICHARDS, James Timothy
    8 A Marloes Road
    Kensington
    W8 5LJ London
    Secrétaire
    8 A Marloes Road
    Kensington
    W8 5LJ London
    British33226480001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secrétaire
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    ALKER, Andrew Stephen
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    Administrateur
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant120642230001
    DONOVAN, Paul Michael
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive190924590002
    GAVIN, Alexander Rupert
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Administrateur
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    EnglandBritishDirector16875680005
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant124301460001
    HARRIS, Roger John
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Administrateur
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritishChief Operating Officer129109390001
    HILDRED, Richard John
    3 Beech Hill
    Mobberley
    WA16 7HT Cheshire
    Administrateur
    3 Beech Hill
    Mobberley
    WA16 7HT Cheshire
    United KingdomBritishUk Finance Director112979700001
    HILDRED, Richard John
    3 Beech Hill
    Mobberley
    WA16 7HT Cheshire
    Administrateur
    3 Beech Hill
    Mobberley
    WA16 7HT Cheshire
    United KingdomBritishCorporate Treasurer112979700001
    MASON, Jonathan Peter
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United Kingdom
    Administrateur
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant117783520001
    RAMSEY, Craig Ray
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    Administrateur
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United StatesAmericanExecutive221321960001
    RIBBONS, Justin Charles
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    Administrateur
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    BritishGeneral Counsel23745010013
    RIBBONS, Justin Charles
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    Administrateur
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    BritishLawyer23745010013
    SINYOR, Joseph
    70 Sheldon Avenue
    N6 4ND London
    Administrateur
    70 Sheldon Avenue
    N6 4ND London
    United KingdomBritishChief Executive Officer142528420002
    WAY, Mark Jonathan
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    Administrateur
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant191239860001
    WILLIAMS, Neil James
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant194329360001
    ESSENTIAL CINEMAS BV
    Amsteldijk 166
    1079 Lh
    Amsterdam
    Netherlands
    Administrateur
    Amsteldijk 166
    1079 Lh
    Amsterdam
    Netherlands
    102479600001
    UNITED CINEMAS INTERNATIONAL MULTIPLEX BV
    Amsteldijk 166
    1079 Lh
    Amsterdam
    Netherlands
    Administrateur
    Amsteldijk 166
    1079 Lh
    Amsterdam
    Netherlands
    102479570001
    UNIVERSAL STUDIOS HOLDING III CORP
    800 Third Avenue
    New York
    Ny 10022
    Usa
    Administrateur
    800 Third Avenue
    New York
    Ny 10022
    Usa
    98626030001
    UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL BV
    Hagedoornlaan 2
    PO BOX 37267
    FOREIGN Amsterdam
    1030 Ag
    Administrateur
    Hagedoornlaan 2
    PO BOX 37267
    FOREIGN Amsterdam
    1030 Ag
    30239060004
    VIACOM INTERNATIONAL (NETHERLANDS) BV
    Naritaweg 207
    1043 Cb Amsterdam
    The Netherlands
    Administrateur
    Naritaweg 207
    1043 Cb Amsterdam
    The Netherlands
    37696370007

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur UCI EXHIBITION (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    United Cinemas International (Uk) Limited
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England
    06 avr. 2016
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Liability Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies, Cardiff
    Numéro d'enregistrement1732125
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    UCI EXHIBITION (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2007
    Livré le 16 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right, title and interest from time to time in and to each of the following assets the material property other than the excluded property the tangible movable property the accounts the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 16 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 03 déc. 2004
    Livré le 14 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Including (I) meteor centre,mansfield rd,derby; DY169137 and (ii) cinema premises adjoining westbrook centre,warrington,cheshire; CH294687. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC,as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 14 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 03 déc. 2004
    Livré le 14 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabiliies due or o become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right,title and interest in (I) cinema premises adjoining westbrook centre,warrington,cheshire; CH294687 and (ii) meteor centre,mansfield rd,derby,dy 169137. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 oct. 2004
    Livré le 09 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    1) meteor centre, mansfield road, derby, DY169137, 2) cinema premises adjoining westbrook centre, warrington, cheshire, CH294687;. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 09 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 28 oct. 2004
    Livré le 09 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all the right, title and interest in the properties k/a cinema premises adjoining westbrook centre, warrington, cheshire t/no CH294687 and meteor centre, mansfield road, derby DY169137.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 déc. 1989
    Livré le 18 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £110,000,000 all monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee not exceeding & under the terms of letters of credit the overdraft facility and any relevant collateral document (as defined)
    Brèves mentions
    (See doc m 395 ref M2616 for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia
    Transactions
    • 18 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Equitable charge.
    Créé le 01 déc. 1989
    Livré le 18 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee the bank of new york national westminster bank PLC and the first national bank of chicago under the terms of any financing document (as defined in a facility agreement dated 1.12.89 and all monies due or to become due from the company under the terms of the charge and all monies due or to become due from the company to the chargee the bank of new york or the banks (as defined facility agreement) under the terms of a guarantee dated 1.12.89.
    Brèves mentions
    Fixed charge all its right title & interest in and to the shares it owns in hollywood express limited and any other shares in the capital of its subsidiary's tog with all moneys dividends bonuses allotments benefits rights proceeds & entitlements.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia
    Transactions
    • 18 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental loan agreement
    Créé le 07 nov. 1989
    Livré le 22 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £64,300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/12/88 and this agreement
    Brèves mentions
    Floating charge over (see doc M550C for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia
    Transactions
    • 22 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    Supplemental loan agreement.
    Créé le 14 sept. 1989
    Livré le 19 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under a loan agreement dated 12/12/88 and this deed.
    Brèves mentions
    Floating charge over (see doc 395 tc 212. for further details).. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia
    Transactions
    • 19 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    Supplemental loan agreement
    Créé le 16 juin 1989
    Livré le 03 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £48,300,000.00 and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12TH december 1988 and this supplemental loan agreement.
    Brèves mentions
    Floating charge over undertaking, property, assets and rights. (See form 395 relative to this charge - ref M569C for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia.
    Transactions
    • 03 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    Loan agreement
    Créé le 12 déc. 1988
    Livré le 28 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or CIC multiplex cinemas B.V. to the chargee, under the terms of the loan agreement
    Brèves mentions
    All properties and interests listed in appendix A. together with floating charge over all undertaking property assets and rights (see from M395, ref M363 for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia
    Transactions
    • 28 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    Deed
    Créé le 09 févr. 1988
    Livré le 01 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for lease dated 15.1.88 and the lease which is to be granted pursuant thereto.
    Brèves mentions
    A deposit of £185,000 paid by amc exhibition UK limited to city grove properties (swansea) limited pursuant to the terms of the deed.
    Personnes ayant droit
    • City Grove Properties (Swansea) Limited
    Transactions
    • 01 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 11 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    UCI EXHIBITION (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 août 2018Dissolved on
    11 oct. 2017Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0