SEABREEZE LEASING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SEABREEZE LEASING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Liquidation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02045936 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SEABREEZE LEASING LIMITED ?
Adresse du siège social | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SEABREEZE LEASING LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2023 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2024 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SEABREEZE LEASING LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 févr. 2025 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 27 févr. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 févr. 2024 |
En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour SEABREEZE LEASING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 25 Gresham Street London EC2V 7HN à 1 More London Place London SE1 2AF le 11 avr. 2024 | 3 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Alyson Elizabeth Mulholland en tant que secrétaire le 18 mars 2024 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Robert Turner en tant que directeur le 30 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Clarke en tant qu'administrateur le 24 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Colin Graham Dowsett en tant que directeur le 22 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 mars 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 1 | 2 pages | MR05 | ||||||||||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 1 | 2 pages | MR05 | ||||||||||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 1 | 2 pages | MR05 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 mars 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Robert Turner en tant qu'administrateur le 13 janv. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gerard Ashley Fox en tant que directeur le 13 janv. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 22 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SEABREEZE LEASING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARKE, Paul | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 318888510001 | ||||
DOREY, Laura Frances Christabel | Administrateur | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 230255280001 | ||||
GITTINS, Paul | Secrétaire | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | British | 45660860003 | ||||||
JOHNSON, Michelle Antoinette Angela | Secrétaire | Floor East Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st England England | 181115820001 | |||||||
LODGE, Matthew Sebastian | Secrétaire | Rose Cottage Dog Lane Stainland HX4 9QF Halifax West Yorkshire | British | 32609030001 | ||||||
MULHOLLAND, Alyson Elizabeth | Secrétaire | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | 241424930001 | |||||||
AITKEN, Joe | Administrateur | 19 Kettilstoun Crescent EH49 6PR Linlithgow West Lothian | British | Banker | 123316840001 | |||||
COCKROFT, Charles Stephen | Administrateur | 34 Cullingworth Road Cullingworth BD13 5BD Bradford West Yorkshire | British | Building Society Secretary | 3990590001 | |||||
COOKE, Timothy John | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | England | British | Director | 120834610001 | ||||
COUZENS, Michael Alastair | Administrateur | Towngate House Towngate Northowram HX3 7DX Halifax West Yorkshire | British | Building Siociety Manager | 75553130001 | |||||
CUMMING, Andrew John | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 46297770002 | ||||
DOWSETT, Colin Graham | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | England | British | Chartered Accountant | 152332230001 | ||||
FOX, Gerard Ashley | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | England | British | Banker | 179100520001 | ||||
GLASSCOE, Keith Roderick | Administrateur | 18 Stanmore Chase AL4 0EZ St Albans Hertfordshire | British | Banker | 126272230001 | |||||
GLEDHILL, Simon Christopher | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | United Kingdom | British | Bank Manager | 191439050001 | ||||
GOODE, Timothy James | Administrateur | Lacey House Lacey Green HP27 0RB Princes Risborough Buckinghamshire | England | British | Treasurer | 26887680002 | ||||
ISAACS, Robin Alexander | Administrateur | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 115548350001 | ||||
JUKES, Anthony Wilfrid | Administrateur | Potts Farm Chennell Park Lane TN30 6XA Tenterden Kent | British | Company Director | 50640090001 | |||||
KEMP, Andrew John | Administrateur | Canons House Canons Way BS1 5LL Bristol Ground Floor United Kingdom | England | British | Director | 222042280001 | ||||
KRAG, Stephen Rosenstjerne | Administrateur | Lee House 40 Pinkneys Drive SL6 6QE Maidenhead Berkshire | British | Chartered Accountant | 70638390003 | |||||
LIVINGSTON, Stewart Fraser | Administrateur | 86 Murrayfield Gardens EH12 6DQ Edinburgh | British | Banker | 111282080002 | |||||
LODGE, Matthew Sebastian | Administrateur | Rose Cottage Dog Lane Stainland HX4 9QF Halifax West Yorkshire | British | Chartered Secretary | 32609030001 | |||||
MCPHERSON, Donald James | Administrateur | 6 Blackwall Rise HX6 2UJ Sowerby Bridge West Yorkshire | British | Chartered Secretary | 40519810001 | |||||
MORRISSEY, John Michael | Administrateur | 66 Selborne Road Southgate N14 7DG London | England | British | Chartered Accountant | 94094650001 | ||||
PETERS, Stephen John | Administrateur | Old Swan Cottage 9 London Road TN16 1BB Westerham Kent | British | Banker | 56296720007 | |||||
PETERS, Stephen John | Administrateur | Old Swan Cottage 9 London Road TN16 1BB Westerham Kent | British | Financial Controller | 56296720007 | |||||
RICHARDS, Ceri | Administrateur | Level 7 Bishopsgate Exchange 155 Bishopsgate EC2M 3YB London | British | Accountant | 70624480004 | |||||
SHARP, Yvonne Easton | Administrateur | 11 Earl Grey Street EH3 9BN Edinburgh New Uberior House Midlothian Scotland | United Kingdom | British | Accountant | 126272440001 | ||||
SHINDLER, David Lawrence | Administrateur | 4 Berkeley Close WD6 3JN Elstree Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 92235400001 | |||||
SMALLWOOD, James Douglas Mortimer | Administrateur | 4 Chestnuts SG13 8AQ Hertford Hertfordshire | England | British | Manager | 110517930001 | ||||
TOWN, Lindsay John | Administrateur | 10 Ferndale TN2 3PB Tunbridge Wells Kent | England | British | Managing Director | 64287260001 | ||||
TURNER, John Robert | Administrateur | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | England | British | Director | 76185650001 | ||||
VELDHUIZEN, Lambertus Hendrik | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | United Kingdom | Dutch | Head Of Ship Finance | 152683120001 | ||||
WILLIAMS, Richard Owen | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | England | British | Head Of Leasing Structured Finance | 164554190001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SEABREEZE LEASING LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Of Scotland Structured Asset Finance Limited | 06 avr. 2016 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
SEABREEZE LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
First priority isle of man statutory ship mortgage | Créé le 01 juil. 2003 Livré le 04 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the company's rights, title and interest present and future to and in 64/64TH shares of which the company is the owner in the vessel and including any share or interest therein and her boats and appurtenances. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
First priority isle of man statutory ship mortgage | Créé le 29 mars 2003 Livré le 01 avr. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions 64/64TH shares of which the company is the owner in the vessel. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
First priority isle of man statutory ship mortgage | Créé le 26 nov. 2002 Livré le 30 nov. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the company's rights title and interest present and future to and in 64/64TH shares of which the company is the owner in the vessel k/a the british trader registered under the isle of man flag with official number 9238038 and including any share or interest therein and her boats and appurtenances. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of covenant | Créé le 10 juil. 2002 Livré le 18 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Hull no 1380 under construction,the 138,000 CUBIC metre lng carrier to be registered under british flag at the port of douglas with all engines,machinery,boats,tackle,outfit,equipment,etc. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of covenant (as defined) | Créé le 18 déc. 2001 Livré le 20 déc. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti The obligation of the company to sell vessel (as defined therein) when required to do so to a purchaser identified by the chargee in accordance with clause 19.2 of a charterparty between the chargor and the chargee dated 18TH december 2001 (the "charterparty") and the obligation of the chargor to make a payment by way of rebate of the charterhire or otherwise to the chargee when required to do so pursuant to clauses 13.2, 18.3.3, and 18.8 of the charterparty. | |
Brèves mentions The 138,000 cubic metre lng carrier bearing hull no. 1381 registered or to be registered at the port of douglas and includes any share or interest in that vessel and its engines, machinery, boats, tackle, outfit, spare gear, fuel, consumable or other stores, belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired (the "vessel"). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of covenant (as defined) | Créé le 18 déc. 2001 Livré le 20 déc. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti The obligation of the company to sell vessel (as defined therein) when required to do so to a purchaser identified by the chargee in accordance with clause 19.2 of a charterparty between the chargor and the chargee dated 18TH december 2001 (the "charterparty") and the obligation of the chargor to make a payment by way of rebate of the charterhire or otherwise to the chargee when required to do so pursuant to clauses 13.2, 18.3.3, and 18.8 of the charterparty. | |
Brèves mentions The 138,000 cubic metre lng carrier bearing hull no. 1416 registered or to be registered at the port of douglas and includes any share or interest in that vessel and its engines, machinery, boats, tackle, outfit, spare gear, fuel, consumable or other stores, belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired (the "vessel"). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
SEABREEZE LEASING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0