SEABREEZE LEASING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSEABREEZE LEASING LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02045936
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SEABREEZE LEASING LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SEABREEZE LEASING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SEABREEZE LEASING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HALIFAX LEASING (DECEMBER NO 2) LIMITED15 sept. 200015 sept. 2000
    HALIFAX LEASING (MARCH) LIMITED 09 oct. 199709 oct. 1997
    HALIFAX LEASING NO. 2 LIMITED04 avr. 199704 avr. 1997
    HALIFAX HOUSING SERVICES LIMITED12 août 198612 août 1986

    Quels sont les derniers comptes de SEABREEZE LEASING LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2023
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2024
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SEABREEZE LEASING LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au13 févr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation27 févr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au13 févr. 2024
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour SEABREEZE LEASING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 25 Gresham Street London EC2V 7HN à 1 More London Place London SE1 2AF le 11 avr. 2024

    3 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 mars 2024

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Alyson Elizabeth Mulholland en tant que secrétaire le 18 mars 2024

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de John Robert Turner en tant que directeur le 30 janv. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Clarke en tant qu'administrateur le 24 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Colin Graham Dowsett en tant que directeur le 22 nov. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 1

    2 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 1

    2 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 1

    2 pagesMR05

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr John Robert Turner en tant qu'administrateur le 13 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gerard Ashley Fox en tant que directeur le 13 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    22 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SEABREEZE LEASING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLARKE, Paul
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director318888510001
    DOREY, Laura Frances Christabel
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector230255280001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    JOHNSON, Michelle Antoinette Angela
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    Secrétaire
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    181115820001
    LODGE, Matthew Sebastian
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    British32609030001
    MULHOLLAND, Alyson Elizabeth
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Cawley House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Cawley House
    United Kingdom
    241424930001
    AITKEN, Joe
    19 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    19 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    BritishBanker123316840001
    COCKROFT, Charles Stephen
    34 Cullingworth Road
    Cullingworth
    BD13 5BD Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    34 Cullingworth Road
    Cullingworth
    BD13 5BD Bradford
    West Yorkshire
    BritishBuilding Society Secretary3990590001
    COOKE, Timothy John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector120834610001
    COUZENS, Michael Alastair
    Towngate House Towngate
    Northowram
    HX3 7DX Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Towngate House Towngate
    Northowram
    HX3 7DX Halifax
    West Yorkshire
    BritishBuilding Siociety Manager75553130001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector46297770002
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    EnglandBritishChartered Accountant152332230001
    FOX, Gerard Ashley
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritishBanker179100520001
    GLASSCOE, Keith Roderick
    18 Stanmore Chase
    AL4 0EZ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    18 Stanmore Chase
    AL4 0EZ St Albans
    Hertfordshire
    BritishBanker126272230001
    GLEDHILL, Simon Christopher
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritishBank Manager191439050001
    GOODE, Timothy James
    Lacey House Lacey Green
    HP27 0RB Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Lacey House Lacey Green
    HP27 0RB Princes Risborough
    Buckinghamshire
    EnglandBritishTreasurer26887680002
    ISAACS, Robin Alexander
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector115548350001
    JUKES, Anthony Wilfrid
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    Administrateur
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    BritishCompany Director50640090001
    KEMP, Andrew John
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Canons House
    Canons Way
    BS1 5LL Bristol
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector222042280001
    KRAG, Stephen Rosenstjerne
    Lee House 40 Pinkneys Drive
    SL6 6QE Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Lee House 40 Pinkneys Drive
    SL6 6QE Maidenhead
    Berkshire
    BritishChartered Accountant70638390003
    LIVINGSTON, Stewart Fraser
    86 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Administrateur
    86 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    BritishBanker111282080002
    LODGE, Matthew Sebastian
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    Administrateur
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    BritishChartered Secretary32609030001
    MCPHERSON, Donald James
    6 Blackwall Rise
    HX6 2UJ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Administrateur
    6 Blackwall Rise
    HX6 2UJ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    BritishChartered Secretary40519810001
    MORRISSEY, John Michael
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    Administrateur
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    EnglandBritishChartered Accountant94094650001
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Administrateur
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    BritishBanker56296720007
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Administrateur
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    BritishFinancial Controller56296720007
    RICHARDS, Ceri
    Level 7 Bishopsgate Exchange
    155 Bishopsgate
    EC2M 3YB London
    Administrateur
    Level 7 Bishopsgate Exchange
    155 Bishopsgate
    EC2M 3YB London
    BritishAccountant70624480004
    SHARP, Yvonne Easton
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Midlothian
    Scotland
    United KingdomBritishAccountant126272440001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant92235400001
    SMALLWOOD, James Douglas Mortimer
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritishManager110517930001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishManaging Director64287260001
    TURNER, John Robert
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector76185650001
    VELDHUIZEN, Lambertus Hendrik
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomDutchHead Of Ship Finance152683120001
    WILLIAMS, Richard Owen
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Leasing Structured Finance164554190001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SEABREEZE LEASING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02279167
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SEABREEZE LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    First priority isle of man statutory ship mortgage
    Créé le 01 juil. 2003
    Livré le 04 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's rights, title and interest present and future to and in 64/64TH shares of which the company is the owner in the vessel and including any share or interest therein and her boats and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Bp Shipping Limited
    Transactions
    • 04 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority isle of man statutory ship mortgage
    Créé le 29 mars 2003
    Livré le 01 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64/64TH shares of which the company is the owner in the vessel. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bp Shipping Limited
    Transactions
    • 01 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority isle of man statutory ship mortgage
    Créé le 26 nov. 2002
    Livré le 30 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's rights title and interest present and future to and in 64/64TH shares of which the company is the owner in the vessel k/a the british trader registered under the isle of man flag with official number 9238038 and including any share or interest therein and her boats and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Bp Shipping Limited
    Transactions
    • 30 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenant
    Créé le 10 juil. 2002
    Livré le 18 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Hull no 1380 under construction,the 138,000 CUBIC metre lng carrier to be registered under british flag at the port of douglas with all engines,machinery,boats,tackle,outfit,equipment,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bp Shipping Limited
    Transactions
    • 18 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenant (as defined)
    Créé le 18 déc. 2001
    Livré le 20 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligation of the company to sell vessel (as defined therein) when required to do so to a purchaser identified by the chargee in accordance with clause 19.2 of a charterparty between the chargor and the chargee dated 18TH december 2001 (the "charterparty") and the obligation of the chargor to make a payment by way of rebate of the charterhire or otherwise to the chargee when required to do so pursuant to clauses 13.2, 18.3.3, and 18.8 of the charterparty.
    Brèves mentions
    The 138,000 cubic metre lng carrier bearing hull no. 1381 registered or to be registered at the port of douglas and includes any share or interest in that vessel and its engines, machinery, boats, tackle, outfit, spare gear, fuel, consumable or other stores, belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired (the "vessel").
    Personnes ayant droit
    • Bp Shipping Limited
    Transactions
    • 20 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenant (as defined)
    Créé le 18 déc. 2001
    Livré le 20 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligation of the company to sell vessel (as defined therein) when required to do so to a purchaser identified by the chargee in accordance with clause 19.2 of a charterparty between the chargor and the chargee dated 18TH december 2001 (the "charterparty") and the obligation of the chargor to make a payment by way of rebate of the charterhire or otherwise to the chargee when required to do so pursuant to clauses 13.2, 18.3.3, and 18.8 of the charterparty.
    Brèves mentions
    The 138,000 cubic metre lng carrier bearing hull no. 1416 registered or to be registered at the port of douglas and includes any share or interest in that vessel and its engines, machinery, boats, tackle, outfit, spare gear, fuel, consumable or other stores, belongings and appurtenances whether on board or ashore and whether now owned or hereafter acquired (the "vessel").
    Personnes ayant droit
    • Bp Shipping Limited
    Transactions
    • 20 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2023L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 12 janv. 2023L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 12 janv. 2023L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 13 janv. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)

    SEABREEZE LEASING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 mars 2024Commencement of winding up
    18 mars 2024Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Matthew Coomber
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0