GOODLANDS HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGOODLANDS HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02052237
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GOODLANDS HOLDINGS LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe GOODLANDS HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o C/O
    MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GOODLANDS HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    S W EIGHTY THREE COMPANY LIMITED03 sept. 198603 sept. 1986

    Quels sont les derniers comptes de GOODLANDS HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour GOODLANDS HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Paul Nigel Hampden Smith en tant que directeur le 28 févr. 2013

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Nigel Hampden Smith en tant que directeur le 28 févr. 2013

    1 pagesTM01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Changement d'adresse du siège social de Travis Perkins Trading Co Ltd Lodge Way, Lodge Farm Industrial Es, Northampton Northamptonshire NN5 7UG le 21 déc. 2011

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 08 déc. 2011

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 oct. 2011

    État du capital au 11 oct. 2011

    • Capital: GBP 1,521,603
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    1 pagesAA

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    1 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    1 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    1 pagesAA

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    1 pagesAA

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de GOODLANDS HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish104472550001
    BACON, Timothy Reginald
    1 Wendover Gardens
    Christchurch
    GL50 2PA Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    1 Wendover Gardens
    Christchurch
    GL50 2PA Cheltenham
    Gloucestershire
    British11336800001
    BUCKMAN, Keith Roy
    4 Hamber Lea
    Bishops Lydeard
    TA4 3NJ Taunton
    Somerset
    Secrétaire
    4 Hamber Lea
    Bishops Lydeard
    TA4 3NJ Taunton
    Somerset
    British16092300001
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    British104472550001
    BACON, Timothy Reginald
    1 Wendover Gardens
    Christchurch
    GL50 2PA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    1 Wendover Gardens
    Christchurch
    GL50 2PA Cheltenham
    Gloucestershire
    British11336800001
    BUCKMAN, Keith Roy
    4 Hamber Lea
    Bishops Lydeard
    TA4 3NJ Taunton
    Somerset
    Administrateur
    4 Hamber Lea
    Bishops Lydeard
    TA4 3NJ Taunton
    Somerset
    British16092300001
    DONALD, Robin Vyvyan Carter
    Osborne House Bathampton Lane
    BA2 6SW Bath
    Avon
    Administrateur
    Osborne House Bathampton Lane
    BA2 6SW Bath
    Avon
    British19164040001
    FISHER, Charles Murray
    Warneford House
    Sudgrove
    GL6 7JD Miserden
    Gloucestershire
    Administrateur
    Warneford House
    Sudgrove
    GL6 7JD Miserden
    Gloucestershire
    United KingdomBritish74765660002
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    MCKAY, Francis John
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Administrateur
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    British78787530001
    MORGAN, Keith Douglas
    Long Meadow
    Blagdon Hill
    TA3 7SF Taunton
    Somerset
    Administrateur
    Long Meadow
    Blagdon Hill
    TA3 7SF Taunton
    Somerset
    British19164050001
    OTLEY, Nicholas William
    Blacknest Farm
    Hinton Blewitt Temple Cloud
    BS39 5AL Bristol
    Avon
    Administrateur
    Blacknest Farm
    Hinton Blewitt Temple Cloud
    BS39 5AL Bristol
    Avon
    British11394040001
    WARES, Hugh David Mcdonald
    12 Old Sneed Park
    BS9 1RF Bristol
    Administrateur
    12 Old Sneed Park
    BS9 1RF Bristol
    British84123870001

    GOODLANDS HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Collateral debenture
    Créé le 29 nov. 1994
    Livré le 03 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from velocity 168 limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of life policy
    Créé le 29 nov. 1994
    Livré le 01 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy of assurance on the life of keith douglas morgan with sun alliance and london assurance company limited no: 9145540. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of life policy
    Créé le 29 nov. 1994
    Livré le 01 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Policy of assurance on the life of nicholas william otley with phoenix assurance PLC numbered 1529537F. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of life policy
    Créé le 29 nov. 1994
    Livré le 01 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the policy of assurance on the life of keith roy buckham with sun alliance and london assurance company limited no: 9145533. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 17 nov. 1994
    Livré le 18 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property being land and buildings at priory road wells somerset t/no.ST65155 and all buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 02 janv. 1990
    Livré le 03 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property at blundells road, tiverton & all buildings & fixtures fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 03 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 05 juin 1989
    Livré le 13 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H premises at audley road chippenham wilts & all buildings fixtures plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 13 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 mai 1989
    Livré le 02 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge by way of legal mortgage and all that f/h premises at brushfordd dulverton.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 02 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 mai 1989
    Livré le 26 mai 1989
    En cours
    Montant garanti
    £30,000 due from the company to burton safe deposit & trust company limited
    Brèves mentions
    Third floor flat 48 queensgate terrace, kensington london SW7.
    Personnes ayant droit
    • Boston Safe Deposite & Trust Company Limited
    Transactions
    • 26 mai 1989Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 30 avr. 1989
    Livré le 09 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property at churchlands rd bedminster bristol avon together with fixed plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 09 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 30 avr. 1989
    Livré le 09 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property at churchlands road bedminster bristol avon title no av 2866. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 09 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 avr. 1989
    Livré le 09 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property at west street and osborne terrace bedminster bristol avon t/no av 2865. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 09 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 avr. 1989
    Livré le 09 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property at west street bedminster bristol avon title no av 77194. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 09 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 avr. 1989
    Livré le 09 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at bludells road tiverton. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 09 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 avr. 1989
    Livré le 09 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at mont road minehead. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 09 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 avr. 1989
    Livré le 09 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H premises at williton industrial estate. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 09 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 avr. 1989
    Livré le 09 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H office & yard at station road williton. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 09 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 30 avr. 1989
    Livré le 05 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 05 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 janv. 1989
    Livré le 21 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of agreement dated 19.12.88
    Brèves mentions
    Stock in trade, work in progress, prepayments, investments quoted on a recognised stock exchange and cash both present & future.
    Personnes ayant droit
    • Ronald Walkins
    Transactions
    • 21 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    Single debenture
    Créé le 30 avr. 1987
    Livré le 06 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 06 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 1987
    Livré le 05 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Stock-in-trade, work-in-progress, pre-payment investments & cash.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 05 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GOODLANDS HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 déc. 2011Commencement of winding up
    25 avr. 2013Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alistair Steven Wood
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    practitioner
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0